S 83 LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàS 83 LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC148181
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di S 83 LTD?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova S 83 LTD?

    Indirizzo della sede legale
    14 Rutland Square
    Edinburgh
    EH1 2BD Midlothian
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di S 83 LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    83 SS LTD14 giu 201614 giu 2016
    83 S LTD02 set 200802 set 2008
    FORT TRADING LIMITED23 dic 199323 dic 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di S 83 LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per S 83 LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 mag 2017, non revisionato

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2017 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio modificato di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2016

    6 pagineAAMD

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 dic 2016 con aggiornamenti

    9 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2016

    7 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere SC1481810024 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1481810022 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1481810023 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1481810019 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1481810012 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1481810011 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1481810015 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1481810017 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1481810013 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1481810018 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1481810010 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name14 giu 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 14 giu 2016

    RES15

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed 83 s LTD\certificate issued on 14/06/16
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name14 giu 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 14 giu 2016

    RES15

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 31 mag 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 23 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 dic 2015

    Stato del capitale al 23 dic 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca SC1481810024, creata il 25 mar 2015

    7 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di S 83 LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Victoria Caroline
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    Segretario
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    British99461500002
    JONES, Steven Alexander
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    Amministratore
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    United KingdomBritish99461360007
    JONES, Victoria Caroline, Mrs.
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    Amministratore
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    United KingdomBritish160627090001
    HENDERSON, Elaine Catherine
    Stonefield House
    22 Park Road
    EH11 3DH Dalkeith
    Segretario
    Stonefield House
    22 Park Road
    EH11 3DH Dalkeith
    British37119590005
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Segretario nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    HENDERSON, Elaine Catherine
    Stonefield House
    22 Park Road
    EH11 3DH Dalkeith
    Amministratore
    Stonefield House
    22 Park Road
    EH11 3DH Dalkeith
    ScotlandBritish37119590005
    JONES, James
    22 Blackford Hill View
    EH9 3HD Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    22 Blackford Hill View
    EH9 3HD Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish902280001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Chi sono le persone con controllo significativo di S 83 LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    EH1 2BD Edinburgh
    14 Rutland Square
    Midlothian
    Scotland
    06 apr 2016
    EH1 2BD Edinburgh
    14 Rutland Square
    Midlothian
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc105694
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Mr Steven Jones
    PH8-0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    United Kingdom
    06 apr 2016
    PH8-0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    United Kingdom
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mrs Victoria Caroline Jones
    PH8-0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    United Kingdom
    06 apr 2016
    PH8-0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    United Kingdom
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    S 83 LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 25 mar 2015
    Consegnato il 02 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    68 hillhouse road, hamilton - title number LAN153173.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Adam & Company PLC
    Transazioni
    • 02 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 feb 2015
    Consegnato il 10 feb 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    56 shandwick place, edinburgh. Basement premises of tenement 54 & 56 shandwick place, edinburgh title number MID123979.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Adam & Co PLC
    Transazioni
    • 10 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 feb 2015
    Consegnato il 10 feb 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    11 north bank street, edinburgh. Title number MID157218.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Adam & Company PLC
    Transazioni
    • 10 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 ott 2013
    Consegnato il 25 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole the subjects in the city parish of edinburgh and county of midlothian (formerly edinburgh) and known as number seventeen ainslie place, edinburgh being the subjects shown delineated and hatched in red on the plan annexed and signed as relative hereto, together with the common property with all the other feuars of the grounds of drumsheugh, in the pleasure grounds of moray place and ainslie place and the banks behind the same being the subjects in the said parish and county described (firstly) and (secondly) in the disposition by testamentary trustees of mrs bella lindsay or edgecombe in favour of the minister of works dated twentieth and twenty first and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the county of midlothian (formerly edinburgh) on thirtieth all days of march nineteen hundred and fifty one; together also with the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto, the fittings and fixtures therein and thereon, and the borrower's whole right, title and interest present and future therein and thereto. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Victoria Caroline Jones
    Transazioni
    • 25 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 ago 2013
    Consegnato il 20 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    6 walker street edinburgh MID143865. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 ago 2013
    Consegnato il 17 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    9 north bank street edinburgh MID131862. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 ago 2013
    Consegnato il 15 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 giu 2013
    Consegnato il 21 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole the ground floor garage premises known as 101 - 103 rose street north lane, edinburgh forming the ground floor of the building comprising garage premises and workshop premises above known as 101 and 103 rose street north lane, edinburgh, being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID110233. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Victoria Caroline Jones
    Transazioni
    • 21 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 giu 2013
    Consegnato il 13 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Subjects known as and forming 32 castle street edinburgh. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 giu 2013
    Consegnato il 17 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole the subjects known as and forming numbers 19 and 20 coates crescent, edinburgh and for the purpose of registration of writs, in the county of midlothian comprising (first) the subjects and others known as number 19 coates crescent, edinburgh in the said county with the solum thereof and ground attached thereto being the subjects more particularly described in and disponed by charter by sir patrick walker of coates with consent thereinmentioned in favour of mrs clara miller and another dated 1 march 1822 with instrument of sasine following thereon in favour of mrs clara miller and another dated 18 april 1823 and recorded in the new particular register of sasines, reversions etcetera for the sheriffdoms of edinburgh and haddington, linlithgow and bathgate on 14 may 1823; together with the cellars under the pavement in front, sunk area, back ground and others effeiring thereto; (second) the subjects known as number 20 coates crescent, edinburgh in the said county together with the cellarage under the pavement in front opposite thereto and the whole other parts, privileges and pertinents effeiring thereto, being the subjects more particularly described in and disponed by disposition by the trustees of the honourable james craufurd, lord ardmillan, with consent thereinmentioned in favour of miss margaret wright dated 3 november 1903 and subsequent dates and recorded in the division of the general register of sasines for the county of edinburgh (now midlothian) on 28 november 1903; which said subjects hereinbefore described (first) and (second) are shown delineated in red on the plan annexed and executed as relative hereto; and (third) a one-half pro indiviso share of all and whole that strip of ground attached to the subjects forming and known as number 11 manor place, edinburgh (which strip of ground forms part of the access to the car park constructed on part of inter alia the subjects (first) and (second) hereinbefore described) in the said county being the subjects shown coloured purple on the said plan annexed and executed as relative hereto and being the subjects more particularly described in and disponed by and delineated and coloured red on the plan annexed and signed as relative to disposition by robert williamson gardiner in favour of mccallum advertising limited and the royal institution of chartered surveyors (therein erroneously referred to as "the scottish branch of the royal institution of chartered surveyors") dated 21 february 1966 and recorded in the division of the general register of sasines for the county of midlothian on 23 february 1966; together also with in relation to the subjects (first), (second) and (third) hereinbefore described (one) the heritable and irredeemable servitude rights of wayleave, passage, access, use and others specified and contained in minute of agreement between the drambuie liqueur company limited and the royal institution of chartered surveyors dated 2 june and 31 july 1967 and recorded in the said division of the general register of sasines and also in the books of council & session on 7 august 1967; (two) the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto; (three) the fittings and fixtures therein and thereon; and (four) the borrower's whole right, title and interest, present and future, therein and thereto; excepting always from the subjects hereinbefore described any rights in coates crescent gardens which were conveyed by disposition by the trustees of adam p nimmo and others to the lord provost, magistrates and council of the city of edinburgh recorded in the said division of the general register of sasines on 29 october 1957. notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Victoria Caroline Jones
    Transazioni
    • 17 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 giu 2013
    Consegnato il 17 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole the subjects forming 8 kew terrace, edinburgh, EH12 5JE being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID53770. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Victoria Caroline Jones
    Transazioni
    • 17 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 mag 2013
    Consegnato il 07 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 02 mag 2013
    Consegnato il 08 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    235 willowbrae road edinburgh see form for details. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 02 mag 2013
    Consegnato il 08 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    358 to 362 morning road edinburgh MID68005. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 02 mag 2013
    Consegnato il 09 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    6 walker street, edinburgh registered under title number MID143865. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Adam & Company PLC
    Transazioni
    • 09 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2013
    Consegnato il 07 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 24 feb 2009
    Consegnato il 28 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    4 walker street, edinburgh MID121987.
    Persone aventi diritto
    • Adam & Company PLC
    Transazioni
    • 28 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 13 dic 2007
    Consegnato il 21 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    235 willowbrae road, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Adam & Company PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Bond & floating charge
    Creato il 23 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Adam & Company PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 19 dic 1996
    Consegnato il 31 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    235 willowbrae road,edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 02 ago 1996
    Consegnato il 07 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 17 mar 1994
    Consegnato il 22 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Willowbrae service station,235 willowbrae road,edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 02 mar 1994
    Consegnato il 03 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0