S 83 LTD
Panoramica
| Nome della società | S 83 LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC148181 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di S 83 LTD?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova S 83 LTD?
| Indirizzo della sede legale | 14 Rutland Square Edinburgh EH1 2BD Midlothian |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di S 83 LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| 83 SS LTD | 14 giu 2016 | 14 giu 2016 |
| 83 S LTD | 02 set 2008 | 02 set 2008 |
| FORT TRADING LIMITED | 23 dic 1993 | 23 dic 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di S 83 LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mag 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per S 83 LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 mag 2017, non revisionato | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2017 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio modificato di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2016 | 6 pagine | AAMD | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 dic 2016 con aggiornamenti | 9 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC1481810024 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC1481810022 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC1481810023 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC1481810019 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC1481810012 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC1481810011 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC1481810015 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC1481810017 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC1481810013 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC1481810018 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC1481810010 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed 83 s LTD\certificate issued on 14/06/16 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 31 mag 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca SC1481810024, creata il 25 mar 2015 | 7 pagine | MR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di S 83 LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Victoria Caroline | Segretario | Stenton Estate PH8 0JB Dunkeld Stenton Estate Perthshire Scotland | British | 99461500002 | ||||||
| JONES, Steven Alexander | Amministratore | Stenton Estate PH8 0JB Dunkeld Stenton Estate Perthshire Scotland | United Kingdom | British | 99461360007 | |||||
| JONES, Victoria Caroline, Mrs. | Amministratore | Stenton Estate PH8 0JB Dunkeld Stenton Estate Perthshire Scotland | United Kingdom | British | 160627090001 | |||||
| HENDERSON, Elaine Catherine | Segretario | Stonefield House 22 Park Road EH11 3DH Dalkeith | British | 37119590005 | ||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Segretario nominato | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| HENDERSON, Elaine Catherine | Amministratore | Stonefield House 22 Park Road EH11 3DH Dalkeith | Scotland | British | 37119590005 | |||||
| JONES, James | Amministratore | 22 Blackford Hill View EH9 3HD Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 902280001 | |||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Amministratore delegato nominato | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di S 83 LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 S Limited | 06 apr 2016 | EH1 2BD Edinburgh 14 Rutland Square Midlothian Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr Steven Jones | 06 apr 2016 | PH8-0JB Dunkeld Stenton Estate United Kingdom | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mrs Victoria Caroline Jones | 06 apr 2016 | PH8-0JB Dunkeld Stenton Estate United Kingdom | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
S 83 LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 25 mar 2015 Consegnato il 02 apr 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 68 hillhouse road, hamilton - title number LAN153173. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 04 feb 2015 Consegnato il 10 feb 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 56 shandwick place, edinburgh. Basement premises of tenement 54 & 56 shandwick place, edinburgh title number MID123979. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 04 feb 2015 Consegnato il 10 feb 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 11 north bank street, edinburgh. Title number MID157218. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 21 ott 2013 Consegnato il 25 ott 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All and whole the subjects in the city parish of edinburgh and county of midlothian (formerly edinburgh) and known as number seventeen ainslie place, edinburgh being the subjects shown delineated and hatched in red on the plan annexed and signed as relative hereto, together with the common property with all the other feuars of the grounds of drumsheugh, in the pleasure grounds of moray place and ainslie place and the banks behind the same being the subjects in the said parish and county described (firstly) and (secondly) in the disposition by testamentary trustees of mrs bella lindsay or edgecombe in favour of the minister of works dated twentieth and twenty first and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the county of midlothian (formerly edinburgh) on thirtieth all days of march nineteen hundred and fifty one; together also with the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto, the fittings and fixtures therein and thereon, and the borrower's whole right, title and interest present and future therein and thereto. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 13 ago 2013 Consegnato il 20 ago 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 6 walker street edinburgh MID143865. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 13 ago 2013 Consegnato il 17 ago 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 9 north bank street edinburgh MID131862. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 13 ago 2013 Consegnato il 15 ago 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 18 giu 2013 Consegnato il 21 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All and whole the ground floor garage premises known as 101 - 103 rose street north lane, edinburgh forming the ground floor of the building comprising garage premises and workshop premises above known as 101 and 103 rose street north lane, edinburgh, being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID110233. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 07 giu 2013 Consegnato il 13 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Subjects known as and forming 32 castle street edinburgh. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 04 giu 2013 Consegnato il 17 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All and whole the subjects known as and forming numbers 19 and 20 coates crescent, edinburgh and for the purpose of registration of writs, in the county of midlothian comprising (first) the subjects and others known as number 19 coates crescent, edinburgh in the said county with the solum thereof and ground attached thereto being the subjects more particularly described in and disponed by charter by sir patrick walker of coates with consent thereinmentioned in favour of mrs clara miller and another dated 1 march 1822 with instrument of sasine following thereon in favour of mrs clara miller and another dated 18 april 1823 and recorded in the new particular register of sasines, reversions etcetera for the sheriffdoms of edinburgh and haddington, linlithgow and bathgate on 14 may 1823; together with the cellars under the pavement in front, sunk area, back ground and others effeiring thereto; (second) the subjects known as number 20 coates crescent, edinburgh in the said county together with the cellarage under the pavement in front opposite thereto and the whole other parts, privileges and pertinents effeiring thereto, being the subjects more particularly described in and disponed by disposition by the trustees of the honourable james craufurd, lord ardmillan, with consent thereinmentioned in favour of miss margaret wright dated 3 november 1903 and subsequent dates and recorded in the division of the general register of sasines for the county of edinburgh (now midlothian) on 28 november 1903; which said subjects hereinbefore described (first) and (second) are shown delineated in red on the plan annexed and executed as relative hereto; and (third) a one-half pro indiviso share of all and whole that strip of ground attached to the subjects forming and known as number 11 manor place, edinburgh (which strip of ground forms part of the access to the car park constructed on part of inter alia the subjects (first) and (second) hereinbefore described) in the said county being the subjects shown coloured purple on the said plan annexed and executed as relative hereto and being the subjects more particularly described in and disponed by and delineated and coloured red on the plan annexed and signed as relative to disposition by robert williamson gardiner in favour of mccallum advertising limited and the royal institution of chartered surveyors (therein erroneously referred to as "the scottish branch of the royal institution of chartered surveyors") dated 21 february 1966 and recorded in the division of the general register of sasines for the county of midlothian on 23 february 1966; together also with in relation to the subjects (first), (second) and (third) hereinbefore described (one) the heritable and irredeemable servitude rights of wayleave, passage, access, use and others specified and contained in minute of agreement between the drambuie liqueur company limited and the royal institution of chartered surveyors dated 2 june and 31 july 1967 and recorded in the said division of the general register of sasines and also in the books of council & session on 7 august 1967; (two) the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto; (three) the fittings and fixtures therein and thereon; and (four) the borrower's whole right, title and interest, present and future, therein and thereto; excepting always from the subjects hereinbefore described any rights in coates crescent gardens which were conveyed by disposition by the trustees of adam p nimmo and others to the lord provost, magistrates and council of the city of edinburgh recorded in the said division of the general register of sasines on 29 october 1957. notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 04 giu 2013 Consegnato il 17 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All and whole the subjects forming 8 kew terrace, edinburgh, EH12 5JE being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID53770. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 30 mag 2013 Consegnato il 07 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 02 mag 2013 Consegnato il 08 mag 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 235 willowbrae road edinburgh see form for details. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 02 mag 2013 Consegnato il 08 mag 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 358 to 362 morning road edinburgh MID68005. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 02 mag 2013 Consegnato il 09 mag 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 6 walker street, edinburgh registered under title number MID143865. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 30 apr 2013 Consegnato il 07 mag 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 24 feb 2009 Consegnato il 28 feb 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 4 walker street, edinburgh MID121987. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 13 dic 2007 Consegnato il 21 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 235 willowbrae road, edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 23 nov 2007 Consegnato il 13 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 19 dic 1996 Consegnato il 31 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 235 willowbrae road,edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 02 ago 1996 Consegnato il 07 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 17 mar 1994 Consegnato il 22 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Willowbrae service station,235 willowbrae road,edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 02 mar 1994 Consegnato il 03 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0