MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED

MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC151333
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?

    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Rutland Court
    Edinburgh
    EH3 8EY
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KENMORE NORTHERN LIMITED15 giu 199515 giu 1995
    KENMORE (NEWCASTLE) LIMITED08 lug 199408 lug 1994
    JADEDELL LIMITED09 giu 199409 giu 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 09 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 lug 2013

    Stato del capitale al 18 lug 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2012

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    3 pagineMG03s

    Bilancio annuale redatto al 09 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Dr Mark Whitworth il 09 mag 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di Dr Mark Whitworth come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alan Barr come amministratore

    2 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2010

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Thomas Eardley Allison come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Baxter come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 09 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2009

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Roy Baxter il 25 nov 2009

    3 pagineCH01

    Nomina di Caroline Ruth Marrison Gill come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di William Bowley come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 lug 2008

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARRISON GILL, Caroline Ruth
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Segretario
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    British147011370001
    ALLISON, Thomas Eardley
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    Scotland
    United Kingdom
    Amministratore
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    Scotland
    United Kingdom
    ScotlandBritish1037730004
    WHITTAKER, John
    Billown Mansion House
    Malew
    IM9 3DL Ballasalla
    Isle Of Man
    Amministratore
    Billown Mansion House
    Malew
    IM9 3DL Ballasalla
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish1614010001
    WHITWORTH, Mark
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish120679580002
    BOWLEY, William John
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    British4171240002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Segretario
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    CHIENE & TAIT
    61 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    Segretario
    61 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    99191230001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Segretario nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    ALLISON, Thomas Eardley
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    Amministratore
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    ScotlandBritish1037730004
    BARR, Alan Andrew
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    Amministratore
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    ScotlandBritish121452150001
    BAXTER, Stephen Roy
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    Amministratore
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    ScotlandBritish86622660005
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Amministratore
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritish462890002
    FINDLAY, Alastair Ian
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish30045540003
    GREEN, David Simon
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    Amministratore
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    British42038120003
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Amministratore
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    KENNEDY, Patricia Alice
    Newhall
    EH26 9LY Carlops
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    Newhall
    EH26 9LY Carlops
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish168440970002
    KENNEDY, Patricia Alice
    Hazlieburn
    EH46 7AS West Linton
    Peeblesshire
    Amministratore
    Hazlieburn
    EH46 7AS West Linton
    Peeblesshire
    British224880001
    SCOTT, Peter Anthony
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    British1674500002
    THOMSON, William George Ritchie
    6 Oswald Road
    EH9 2HF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    6 Oswald Road
    EH9 2HF Edinburgh
    Midlothian
    British72331280001
    WHARTON, Kenneth John
    Cornercroft
    7 Glendyke Road
    L18 6JR Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    Cornercroft
    7 Glendyke Road
    L18 6JR Liverpool
    Merseyside
    British9964160002
    WHITE, Andrew Edward
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish110163980001
    WILLIAMS, Thomas David
    23 Woodlands Road
    L37 2JN Formby
    Merseyside
    Amministratore
    23 Woodlands Road
    L37 2JN Formby
    Merseyside
    British51662010001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    MARITIME CENTRE (NO. 2) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 28 feb 2007
    Consegnato il 08 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage, fixed charges, assignments and floating charge - see form 410 paper apart for full details.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Creato il 23 feb 2007
    Consegnato il 08 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Standard security
    Creato il 16 apr 1999
    Consegnato il 21 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Unit 25, whistleberry road, whistleberry industrial estate, hamilton.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 15 ago 1995
    Consegnato il 21 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Floating charge on all assets and fixed charge over property at commercial street, rothwell, leeds, registered under title number wyk 103921.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 24 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 01 giu 1995
    Consegnato il 16 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0