DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS LIMITED
Panoramica
Nome della società | DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC152362 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS LIMITED?
- fabbricazione di altre apparecchiature elettriche (27900) / Industrie manifatturiere
Dove si trova DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 74 Black Street G4 0EF Glasgow |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 14 apr 2020
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di William Richardson come amministratore in data 18 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Trevor Mark Sinkinson come amministratore in data 18 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 29 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Trevor Mark Sinkinson il 02 mag 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Gregor John Mathers come amministratore in data 01 set 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Niall Ross Macmillian come amministratore in data 01 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 29 pagine | AA | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATHERS, Gregor John | Amministratore | Crompton Close SS14 3BA Basildon C/O Gilbarco Veeder Root England | Scotland | British | Finance Director | 171739330001 | ||||
CUNNINGHAM, Neil Gillies | Segretario | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Strathclyde | British | Solicitor | 43086330001 | |||||
GEMMELL, Donald Johnson | Segretario | Fairdale Glen Road FK15 0DJ Dunblane Perthshire | British | Chartered Accountant | 14320230002 | |||||
HAMPTON, Brian Frank, Dr | Segretario | 3 Mitchell Drive Milngavie G62 6PY Glasgow | British | 43169310001 | ||||||
MUIR, Stuart Macfarlane | Segretario | 10 Sherifflats Road ML12 6PA Thankerton Lanarkshire | British | Accountant | 100044330001 | |||||
TUNLEY, David William | Segretario | Manor Farm Close Aughton S26 3XY Sheffield 27 South Yorkshire | British | Accountant | 134992820001 | |||||
WATT, Allan Harvey | Segretario | Burlington Avenue G12 0LQ Glasgow 10 | British | 130864340001 | ||||||
ATALLA, Mahmoud Riyad | Amministratore | Elizabeth Street Belgravia SW1W 9PP London 43a | England | British | Private Equity | 128482790001 | ||||
CUNNINGHAM, Neil Gillies | Amministratore | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Strathclyde | British | Solicitor | 43086330001 | |||||
DRUMMOND, Alphonsus Sean | Amministratore | Rowley Close BT33 0UE Newcastle 7 County Down Northern Ireland | United Kingdom | British | Finance Controller | 138522220001 | ||||
FARISH, Owen, Professor | Amministratore | 1 Ardoch Road Bearsden G61 2BB Glasgow | United Kingdom | British | Professor | 43167780001 | ||||
GREENLEES, Nelson Jonathan | Amministratore | Black Street G4 0EF Glasgow 74 Scotland | Scotland | British | None | 190254200001 | ||||
HAKANSSON, Kurt Ake | Amministratore | Rainstrasse 405 8706 Feldmeilen Switzerland | Switzerland | Swedish | Company Director | 190400550001 | ||||
HAMPTON, Brian Frank, Dr | Amministratore | 3 Mitchell Drive Milngavie G62 6PY Glasgow | British | Marketing Director | 43169310001 | |||||
MACMILLIAN, Niall Ross | Amministratore | Crompton Close SS14 3BA Basildon Gilbarco Veeder Root England | England | British | Director | 212682440001 | ||||
MCDONALD, James Rufus | Amministratore | 48 Colonsay Drive Newton Mearns G77 6TY Glasgow | British | Univ | 42386710001 | |||||
MURPHY, Michael Gerard | Amministratore | 3 Broomley Drive Giffnock G46 6PD Glasgow Strathclyde | British | Solicitor | 1122250002 | |||||
PEARSON, John | Amministratore | Craigmohr Mearns Road G77 6RS Glasgow | British | Managing Director | 116772140001 | |||||
REHMAN, Fasih | Amministratore | Gesegnetmattstrasse 6 Luzern 6006 Switzerland | British | Director | 128050470001 | |||||
RICHARDSON, William | Amministratore | Levernside Avenue Barrhead G78 1LW Glasgow 5 | Scotland | British | General Manager | 170808050001 | ||||
SHEIN, Kenneth Kyaw | Amministratore | 38141 Creekview Circle Murietta California Usa | American | Company Director | 118439990001 | |||||
SINKINSON, Trevor Mark | Amministratore | Crompton Close SS14 3BA Basildon C/O Gilbarco Veeder-Root England | United Kingdom | British | Director | 198489200001 | ||||
TAGGART, Kenneth Andrew Wade | Amministratore | 6 Dalmellington Court G74 4XD East Kilbride Strathclyde | British | Accountant | 74781230001 | |||||
TUNLEY, David William | Amministratore | Manor Farm Close Aughton S26 3XY Sheffield 27 South Yorkshire | Uk | British | Accountant | 134992820001 | ||||
WARD, Keith Graham | Amministratore | 12 Rosedene Gardens GU51 4NQ Fleet Hampshire | England | British | Finance Director | 32236660001 | ||||
WATT, Allan Harvey | Amministratore | Burlington Avenue G12 0LQ Glasgow 10 | Scotland | British | None | 170808080001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tga Industries Limited | 02 lug 2016 | Crompton Close SS14 3BA Basildon Gilbarco Veeder Root England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Pledge agreement | Creato il 01 set 2008 Consegnato il 17 set 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 715 shares of pdtech power engineering ag and all rights money or property of a capital and income nature accruing on or payable or receivable in respect of any of the pledged shares. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage of shares, securities and negotiable instruments | Creato il 10 gen 2007 Consegnato il 30 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All present and future right, title and interest in: the marketable securities and the new rights. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 10 gen 2007 Consegnato il 30 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 22 apr 2002 Consegnato il 09 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 17 dic 1998 Consegnato il 30 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0