STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED

STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC153127
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED?

    • (4521) /

    Dove si trova STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Regency House
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUNWILCO (416) LIMITED16 set 199416 set 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    3 pagineMG03s

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approve sale entire share capital of subsidiary 07/09/2011
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approve sale entire share cap of subsidiary 06/09/2011
    RES13

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    11 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    4 pagineMG05s

    legacy

    4 pagineMG05s

    Bilancio annuale redatto al 27 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 ago 2011

    Stato del capitale al 03 ago 2011

    • Capitale: GBP 500
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share purchase agreement approved 28/01/2011
    RES13

    legacy

    3 pagineMG02s

    Bilancio annuale redatto al 27 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di David Gaffney come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA

    Nomina di Mr Colin Edward Lewis come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Neil Fitzsimmons come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ in data 02 feb 2010

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 29 gen 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808750001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    LEES, Gordon
    8 Grange Gardens
    Monifieth
    DD5 4NA Tayside
    Segretario
    8 Grange Gardens
    Monifieth
    DD5 4NA Tayside
    British82127910001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Segretario
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    BritishCompany Secretary606150007
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Segretario
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    British78545300002
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Segretario
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    BritishSolicitor562500001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Segretario nominato
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900004640001
    BETHUNE, Hamish William
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    Amministratore
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    BritishCompany Director1198020003
    COOPER, James Arthur
    4 Maclean Grove
    East Kilbride
    G74 4TJ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    4 Maclean Grove
    East Kilbride
    G74 4TJ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCompany Director43500170001
    COUTTS, Maureen Sheila
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004630001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director35117250001
    FRASER, Gordon Mackenzie
    Cortachy Cottage
    Auchterhouse
    Dundee
    Amministratore
    Cortachy Cottage
    Auchterhouse
    Dundee
    BritishChartered Surveyor16138750005
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    HARDIE, David
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004620001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Amministratore
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    ScotlandBritishFinance Director83466350002
    OGILVIE, Stuart
    46 Holly Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LZ Dundee
    Amministratore
    46 Holly Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LZ Dundee
    BritishChartered Surveyor39560000001
    WHITAKER, David Alexander
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    Amministratore
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    ScotlandBritishCompany Director26878690001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Amministratore
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritishProperty Developer161858620001

    STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 16 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 21 set 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (MG05s)
    • 03 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Shares pledge
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 15 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due all sums due or to become due
    Brevi particolari
    900 ordinary shares in castlegait homes limited.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Shares pledge
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 15 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    12,100 ordinary shares over glademartin homes limited.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 24 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Floating charge
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 15 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 14 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 21 set 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (MG05s)
    • 03 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 08 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 26 set 2001
    Consegnato il 04 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 03 feb 1995
    Consegnato il 14 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0