SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED

SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC155408
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    • (1598) /

    Dove si trova SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Third Floor West Edinburgh Quay 2
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPEYSIDE GLENLIVIT WATER COMPANY LIMITED21 mar 199521 mar 1995
    M M & S (2247) LIMITED18 gen 199518 gen 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Conto finale prima della dissoluzione in CVL

    12 pagineLIQ14(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da * Atholl Exchange 6 Canning Street Edinburgh EH3 8EG* in data 13 mar 2013

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 2Nd Floor, Capital House 2 Festival Square Edinburgh Midlothian EH3 9SU* in data 25 gen 2012

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Invocas 2Nd Floor, Langstane House 221/229 Union Street Aberdeen AB11 6DR* in data 15 apr 2011

    2 pagineAD01

    Avviso di passaggio dall'amministrazione alla liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine2.25B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    11 pagine2.20B(Scot)

    legacy

    2 pagine2.18B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    8 pagine2.20B(Scot)

    legacy

    19 pagine2.18B(Scot)

    Proposta dell'amministratore

    13 pagine2.16B(Scot)

    Nomina di un amministratore

    3 pagine2.11B(Scot)

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    4 pagine410(Scot)

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2006

    14 pagineAA

    legacy

    42 pagine363a

    legacy

    3 pagine88(2)R

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2005

    15 pagineAA

    legacy

    6 pagine410(Scot)

    legacy

    3 pagine419a(Scot)

    legacy

    42 pagine363a

    legacy

    3 pagine88(2)R

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROSS, Gavin Maxwell
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    Segretario
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    British7130710001
    DRESHER, Leontina Megan
    Chilworth Springs
    Chilworth Farm
    OX44 7JH Great Milton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Chilworth Springs
    Chilworth Farm
    OX44 7JH Great Milton
    Oxfordshire
    United KingdomHungarian30141330001
    PRICE, Stephen
    The Willows
    Water Stratford
    MK18 5DU Buckingham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Willows
    Water Stratford
    MK18 5DU Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish73146560001
    ROSS, Gavin Maxwell
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    Amministratore
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    EnglandBritish7130710001
    CLARK, Patricia Ann
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    Segretario
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    British68375010001
    CUTHBERT, Bernice Margaret
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    Segretario
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    British70901470001
    HELLIWELL, David
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    Segretario
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    British61424220001
    KINLOCH, Henry, Dr
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    Segretario
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    British57563390001
    SMITH, David
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    British74298510001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Segretario
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    British14578540001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Segretario
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    British14578540001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Segretario nominato
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    ANDERSON, John Arthur
    Manx Farm Steep Hill
    Chobham
    GU24 8SZ Woking
    Surrey
    Amministratore
    Manx Farm Steep Hill
    Chobham
    GU24 8SZ Woking
    Surrey
    EnglandBritish34883320001
    BEVAN, Jonathan Stuart Vaughan
    1 Eaton Gate
    SW1W 9BA London
    Amministratore
    1 Eaton Gate
    SW1W 9BA London
    British39232450001
    CHILD, Peter John
    3 Danson Mead
    DA16 1RU Welling
    Kent
    Amministratore
    3 Danson Mead
    DA16 1RU Welling
    Kent
    British24036010001
    CLARK, Patricia Ann
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    Amministratore
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    British68375010001
    COURTNEY, John Adam
    70west Riding
    Bricket Wood
    AL2 3QQ St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    70west Riding
    Bricket Wood
    AL2 3QQ St Albans
    Hertfordshire
    British15297560005
    CUTHBERT, Bernice Margaret
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    Amministratore
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    United KingdomBritish70901470001
    EVERETT, Grace Mary
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    British70901230001
    EVERETT, Timothy John
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    United KingdomBritish70901170001
    FERNBACK, Alan Geoffrey
    20 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Orpington
    The Tudors
    Kent
    Amministratore
    20 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Orpington
    The Tudors
    Kent
    EnglandBritish38497170001
    HEINRICH, Gisbert
    15 Windsor Close
    Read
    BB12 7QH Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    15 Windsor Close
    Read
    BB12 7QH Burnley
    Lancashire
    British44530030001
    HELLIWELL, David
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    Amministratore
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    EnglandBritish61424220001
    KINLOCH, Henry, Dr
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish57563390001
    MARNER, Christian
    Kingwood Stud
    Lambourn Woodlands
    RG17 7RS Hungerford
    Berkshire
    Amministratore
    Kingwood Stud
    Lambourn Woodlands
    RG17 7RS Hungerford
    Berkshire
    Danish52354890003
    MILLAR, Andrew Donaldson
    29 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PG London
    Amministratore
    29 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PG London
    British116870001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Amministratore
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    United KingdomBritish14578540001
    SULLY, Malcolm Keith
    4 Northwood Drive
    HA6 2YU Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    4 Northwood Drive
    HA6 2YU Northwood
    Middlesex
    British39278310002
    WOOD - ROBERTS, David
    West Knole House
    Knole
    TA10 9HY Langport
    Somerset
    Amministratore
    West Knole House
    Knole
    TA10 9HY Langport
    Somerset
    British64744510006
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 12 mar 2008
    Consegnato il 02 apr 2008
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Floating charge over 1 x 2007 zambelli fully automatic trayloader/shrink wrapping machine, model number LFT20/v single lane version - serial number 4621.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Commercial Asset Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 02 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 02 nov 2006
    Consegnato il 22 nov 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    As continuing security for the payment or discharge othe secured liabilities all of the equipment and other chattels. See form 410 for further details.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 22 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Bond & floating charge
    Creato il 29 apr 2004
    Consegnato il 14 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 10 set 1999
    Consegnato il 23 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Speyside Glenlivet Limited
    Transazioni
    • 23 set 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 mar 2009Inizio dell'amministrazione
    04 mar 2010Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Colin Andrew Albert Murdoch
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Praticante
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Donald Iain Mcnaught
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    Praticante
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    2
    DataTipo
    04 mar 2010Inizio della liquidazione
    14 nov 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Colin Andrew Albert Murdoch
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Praticante
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Donald Iain Mcnaught
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    Praticante
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0