SCOTTISH INSTITUTE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGY LIMITED
Panoramica
Nome della società | SCOTTISH INSTITUTE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGY LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC157070 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SCOTTISH INSTITUTE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGY LIMITED?
- Attività di consulenza ambientale (74901) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SCOTTISH INSTITUTE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGY LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Eastfield House Eastfield Road EH28 8LS Edinburgh |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SCOTTISH INSTITUTE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGY LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PACIFIC SHELF 629 LIMITED | 31 mar 1995 | 31 mar 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SCOTTISH INSTITUTE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGY LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per SCOTTISH INSTITUTE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGY LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2015 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mrs Victoria Jayne Hall-Sturt come segretario in data 02 gen 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul William Jowitt come amministratore in data 02 gen 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Ann Moist come segretario in data 02 gen 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Stato del capitale al 17 mar 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
Nomina di Sarah Ann Moist come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Derek Brown come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Heriot Watt University Riccarton Edinburgh EH14 4AS* in data 07 mar 2014 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SCOTTISH INSTITUTE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGY LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALL-STURT, Victoria Jayne | Segretario | 1 Cranbrook Way Shirley B90 4GT Solihull Pegasus House West Midlands England | 193789120001 | |||||||
SMITH, David Anthony | Amministratore | c/o Mwh Uk Ltd Birchwood WA3 6GD Warrington Temple Court Cheshire England | United Kingdom | British | Strategy Director | 128360030001 | ||||
BROWN, Derek Gardiner | Segretario | 16 Leslie Way EH42 1GP Dunbar East Lothian | British | 46684340002 | ||||||
MOIST, Sarah Ann | Segretario | 1 Cranbrook Way Solihull Business Park B90 4GT Solihull Pegasus House West Midlands England | British | 185737400001 | ||||||
SKUTECKI, Alan | Segretario | 6 Old Farm Court Pencaitland EH34 5HL Tranent East Lothian | British | 28313090005 | ||||||
MD SECRETARIES (EDINBURGH) LIMITED | Segretario | Pacific House 70 Wellington Street G2 6SB Glasgow | 43825370001 | |||||||
SCOTTISH BORDERS ENTERPRISE LIMITED | Segretario | Bridge Street TD1 1SW Galashiels Borders | 48789050001 | |||||||
BRYDON, Donald Lithgow, Professor | Amministratore | The Hedges Gattonside TD6 9NB Melrose Scottish Borders | British | Vice-Principal | 93230190001 | |||||
CORBETT, Patrick William Michael | Amministratore | Thirlestane Road EH1 9AS Edinburgh 108 | Scotland | British | Professor | 213844880001 | ||||
COX, Gordon Sherrington | Amministratore | 10 Haining Park TD7 5AW Selkirk Selkirkshire | British | Snr.Business Development Exec. | 16480810001 | |||||
DOUGLAS, David Pringle | Amministratore | Weirgate House TD6 0BD St Boswells Roxburghshire | British | Executive Director | 48789270001 | |||||
FORREST, Robert Jack | Amministratore | Scotston Park TD11 3QL Duns Berwickshire | United Kingdom | British | Farmer | 67755080002 | ||||
HART, Iain Mcdonald | Amministratore | 2 Roadside Cumbernauld G67 2SR Glasgow Lanarkshire Scotland | British | Company Director | 17569710001 | |||||
HEALEY, Brian | Amministratore | 6 Whitelea Crescent EH14 7HF Balerno Midlothian | British | Environmental Management | 73287310001 | |||||
HOGGART, Christopher Robert | Amministratore | Beaconsfield Avenue HP13 5EN High Wycombe 6 Buckinghamshire | England | British | Chartered Scientist | 128092970001 | ||||
JONES, Christine Jane | Amministratore | 12a Eglinton Crescent EH12 5DD Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Manager | 103127290001 | ||||
JOWITT, Paul William, Professor | Amministratore | 14 Belford Mews EH4 3BT Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Academic | 101626300001 | ||||
LLANWARNE, Andrew Sherring | Amministratore | 8 Glasclune Way Broughty Ferry DD5 3TJ Dundee Angus | Scotland | British | Director | 71766810001 | ||||
MADDOX, Christopher Edward Ralph, Professor | Amministratore | 53 Ladhope Crescent TD1 2BN Galashiels | British | Retired University Professor | 33983550002 | |||||
MCCHORD, Cormick Keenan | Amministratore | 4 Mayfield Court FK7 0BX Stirling | United Kingdom | British | Elected Member Council | 69777130001 | ||||
MURRAY, James Lothian, Professor | Amministratore | 32 Westgarth Avenue EH13 0BD Edinburgh Lothian | British | Consultant | 1166920001 | |||||
OWEN, David Gareth, Professor | Amministratore | 7 Oak Lane EH12 6XH Edinburgh Midlothian | British | University Professor | 1381380001 | |||||
RENNET, Roderick James | Amministratore | 1a Polwarth Terrace EH11 1NF Edinburgh Lothians Scotland | British | Retired | 60723240001 | |||||
TAYLOR, Anthony Bichard | Amministratore | The Coach House Bowden TD6 0SS Melrose Roxburghshire | Scotland | British | Company Director | 195370006 | ||||
WARING, David Walter | Amministratore | Craigmohr,30 Millbank KY15 5DP Cupar Fife | British | Director | 76171990004 | |||||
WILSON, Mark | Amministratore | Wellcroft Gardens WA13 0LU Lymm 32 Cheshire | England | British | Business Director | 134729620001 | ||||
WILSON, Peter Liddell, Dr | Amministratore | 6 Mansfield Road EH14 7LA Balerno Midlothian | Scotland | British | University Secretary | 1233920002 | ||||
MD SECRETARIES (EDINBURGH) LIMITED | Amministratore | Pacific House 70 Wellington Street G2 6SB Glasgow | 43825370001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SCOTTISH INSTITUTE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGY LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mwh Uk Limited | 06 apr 2016 | Kingsmead Business Park, Frederick Place London Road HP11 1JU High Wycombe Buckingham Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Heriot Watt University | 06 apr 2016 | Riccarton EH14 4AS Edinburgh Heriot Watt Universoty Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
SCOTTISH INSTITUTE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Creato il 12 feb 1999 Consegnato il 22 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0