ELDERS PHARMACIES LIMITED

ELDERS PHARMACIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàELDERS PHARMACIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC157566
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ELDERS PHARMACIES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ELDERS PHARMACIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ELDERS PHARMACIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ELDERS PHARMACIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 24 lug 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 feb 2012

    Stato del capitale al 05 feb 2012

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland in data 20 gen 2012

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 193 Bath Street Glasgow G2 4HU in data 28 lug 2010

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 set 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Neil Midmer il 27 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Kamma Foulkes il 27 ott 2009

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di ELDERS PHARMACIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish163496070001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Segretario
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Segretario
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Segretario
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Segretario
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    158304980001
    MCLEISH, William David
    c/o Southern Cross Healthcare
    The Castle Business Park
    Lomond Court
    FK9 4TU Ground Floor Unit 2
    Stirling
    Scotland
    Segretario
    c/o Southern Cross Healthcare
    The Castle Business Park
    Lomond Court
    FK9 4TU Ground Floor Unit 2
    Stirling
    Scotland
    British168970640001
    NIVEN, Norman
    61 Barcheston Road
    Cheadle
    SK8 1LJ Stockport
    Cheshire
    Segretario
    61 Barcheston Road
    Cheadle
    SK8 1LJ Stockport
    Cheshire
    English28365230001
    ROACH, Paul Vyvyan
    65 Greenfields Avenue
    Appleton
    WA4 3BW Warrington
    Segretario
    65 Greenfields Avenue
    Appleton
    WA4 3BW Warrington
    British61280700002
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    DALGLEN SECRETARIES LIMITED
    Dalmore House
    310 St Vincent Street
    G2 5QR Glasgow
    Strathclyde
    Segretario nominato
    Dalmore House
    310 St Vincent Street
    G2 5QR Glasgow
    Strathclyde
    900015270001
    ATWILL, Robert Frederick
    46 Saint Johns Avenue
    WA16 0DH Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    46 Saint Johns Avenue
    WA16 0DH Knutsford
    Cheshire
    British61398460002
    BOLOT, Timothy James
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    c/o Southern Cross Healthcare
    The Castle Business Park
    Lomond Court
    FK9 4TU Ground Floor Unit 2
    Stirling
    Scotland
    Amministratore
    c/o Southern Cross Healthcare
    The Castle Business Park
    Lomond Court
    FK9 4TU Ground Floor Unit 2
    Stirling
    Scotland
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Amministratore
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Amministratore
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    Amministratore
    193 Bath Street
    Glasgow
    G2 4HU
    United KingdomBritish111188390002
    GITSHAM, Andrew Michael
    34 Broomfield Road
    Heaton Moor
    SK4 4ND Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    34 Broomfield Road
    Heaton Moor
    SK4 4ND Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish41402740002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Amministratore
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Amministratore
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Amministratore
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    KERR, Andrew
    33 Vermont Close
    Great Sankey
    WA5 5WX Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    33 Vermont Close
    Great Sankey
    WA5 5WX Warrington
    Cheshire
    British62025650002
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100131200001
    MCNAUGHTON, David Malcolm
    Iona 37 Dunbar Road
    EH41 3PJ Haddington
    East Lothian
    Amministratore
    Iona 37 Dunbar Road
    EH41 3PJ Haddington
    East Lothian
    British25943360001
    MIDMER, Richard Neil
    The Castle Business Park, Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    C/O Southern Cross Healthcare
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    The Castle Business Park, Lomond Court
    Ground Floor, Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    C/O Southern Cross Healthcare
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    NIVEN, Norman
    61 Barcheston Road
    Cheadle
    SK8 1LJ Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    61 Barcheston Road
    Cheadle
    SK8 1LJ Stockport
    Cheshire
    United KingdomEnglish28365230001
    RHODES, Colin Eric
    12 Alexandra Park
    Lenzie
    G66 5BH Glasgow
    Amministratore
    12 Alexandra Park
    Lenzie
    G66 5BH Glasgow
    British3918330003
    ROACH, Paul Vyvyan
    65 Greenfields Avenue
    Appleton
    WA4 3BW Warrington
    Amministratore
    65 Greenfields Avenue
    Appleton
    WA4 3BW Warrington
    British61280700002
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Amministratore
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    c/o Southern Cross Healthcare
    The Castle Business Park
    Lomond Court
    FK9 4TU Ground Floor Unit 2
    Stirling
    Scotland
    Amministratore
    c/o Southern Cross Healthcare
    The Castle Business Park
    Lomond Court
    FK9 4TU Ground Floor Unit 2
    Stirling
    Scotland
    United KingdomBritish147997950001

    ELDERS PHARMACIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond & floating charge
    Creato il 20 ago 1996
    Consegnato il 28 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Whole company assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 18 lug 1995
    Consegnato il 24 lug 1995
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Ashbourne PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (410)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0