KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED

KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione controllata
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC158115
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Midlothian
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KILMARTIN PROPERTIES LIMITED18 mag 199518 mag 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 apr 2009
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 gen 2010
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2008

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al18 mag 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma01 giu 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Indirizzo della sede legale modificato da * Erskine House, 2Nd Floor, 68-73 Queen Street Edinburgh Midlothian EH2 4NH* in data 04 apr 2014

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH United Kingdom* in data 25 mar 2010

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Robert Wotherspoon come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neil Mcguinness come amministratore

    2 pagineTM01

    Avviso di nomina del ricevitore da parte di un detentore di carica flottante

    2 pagine1(Scot)

    Cessazione della carica di Jonathan Ridehalgh come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio consolidato redatto al 30 apr 2008

    32 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    3 pagine410(Scot)

    legacy

    3 pagine410(Scot)

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    9 pagine410(Scot)

    legacy

    3 pagine410(Scot)

    legacy

    3 pagine410(Scot)

    legacy

    3 pagine410(Scot)

    Chi sono gli amministratori di KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ORR, Martin
    2 Lothian Bank
    Dalkeith
    EH22 3AN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    2 Lothian Bank
    Dalkeith
    EH22 3AN Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish114402810001
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Segretario
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003420001
    BALL, Nicholas Spencer
    5 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish105270210001
    BOWDER, Simon Hugo
    The Piggeries
    Hog Lane, Ashley Green
    HP5 3PS Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Piggeries
    Hog Lane, Ashley Green
    HP5 3PS Chesham
    Buckinghamshire
    British105270120001
    BRYAN, James Hamilton
    95 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Rutland
    Leicestershire
    Amministratore
    95 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Rutland
    Leicestershire
    United KingdomBritish149263980001
    FORSYTH, James Patrick Alistair
    21 Stonehill Road
    SW14 8RR London
    Amministratore
    21 Stonehill Road
    SW14 8RR London
    British127040003
    HANCOCK, Mark Edward
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritish141515870001
    JEPSON, Martin Clive
    5 Longcroft Avenue
    SM7 3AE Banstead
    Surrey
    Amministratore
    5 Longcroft Avenue
    SM7 3AE Banstead
    Surrey
    United KingdomBritish92627900001
    KERR, Adam Charles
    Snail Hall Millwood Road
    Polstead
    CO6 5AU Colchester
    Essex
    Amministratore
    Snail Hall Millwood Road
    Polstead
    CO6 5AU Colchester
    Essex
    United KingdomBritish141326000001
    KERSHAW, Adrian
    17 Summerside Street
    EH6 4NT Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    17 Summerside Street
    EH6 4NT Edinburgh
    Midlothian
    British116630690001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Amministratore
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    United KingdomBritish83466350002
    MITCHELL, David Frank Robert
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Amministratore
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    British97869190001
    PECK, David Howard
    Muirwood
    Bankrugg
    EH41 4JS Gifford
    East Lothian
    Amministratore
    Muirwood
    Bankrugg
    EH41 4JS Gifford
    East Lothian
    British48939900005
    RIDEHALGH, Jonathan Mark
    Burnt House Farm
    Blacko
    BB9 6RG Nelson
    Lancashire
    Amministratore
    Burnt House Farm
    Blacko
    BB9 6RG Nelson
    Lancashire
    United KingdomBritish76321080001
    SMITH, Alexander
    17 Cargil Terrace
    EH5 3ND Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    17 Cargil Terrace
    EH5 3ND Edinburgh
    Lothian
    British76129550001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Amministratore
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish161858620001
    REYNARD NOMINEES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore delegato nominato
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900011050001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore delegato nominato
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003410001

    KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 31 mar 2008
    Consegnato il 09 apr 2008
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground to west of stoneywood papermill, dyce, aberdeen ABN95936.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 13 mar 2008
    Consegnato il 25 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The area of ground extending to 0.216 hectares or thereby lying to the east of leith street in the city of edinburgh and county of midlothian.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    Legal charge
    Creato il 21 gen 2008
    Consegnato il 23 gen 2008
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over freehold property known as miller arcade, preston LA552104.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 04 ott 2007
    Consegnato il 09 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest in lease over 9 longman drive, inverness INV4137.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 04 ott 2007
    Consegnato il 09 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest in lease over 7 longman drive, inverness INV6983.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 03 ott 2007
    Consegnato il 16 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    7A inshes holdings, inverness.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 03 ott 2007
    Consegnato il 16 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    3.92 hectare development site at the inshes holdings, inverness.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 30 apr 2007
    Consegnato il 08 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    78 and 84-90 glasgow street, dumfries DMF15650.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 04 dic 2006
    Consegnato il 06 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Unit 7, pentland industrial estate, loanhead MID88399.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 08 nov 2006
    Consegnato il 22 nov 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Unit c, plot 3(known as 5 livingstone boulevard), hamilton international technology park, blantyre.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 12 ott 2006
    Consegnato il 20 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Unit 1, hareness road, aberdeen KNC4408.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 31 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 10 ago 2006
    Consegnato il 15 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    84/86 prestwick road, ayr AYR52114.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 02 giu 2006
    Consegnato il 12 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects known as cherrybank, perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 gen 2006
    Consegnato il 04 feb 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Unit 2, hamilton road, hallside, cambuslang LAN117711.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 06 dic 2005
    Consegnato il 12 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    9 high street, inverness.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 09 nov 2005
    Consegnato il 18 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at 15-17 high street, dingwall...see mortgage document for full description.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 09 nov 2005
    Consegnato il 12 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    That plot or area of ground in the former royal burgh and parish of dingwall and county of ross and cromarty extending to five hundred and four one thousandth parts of an acre or thereby (see form 410 paper apart for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 14 giu 2005
    Consegnato il 28 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all the freehold/leasehold property known as brunel gate, aylesbury (title number BM213744).
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 29 nov 2004
    Consegnato il 16 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    7 nettlehill road, livingston, west lothian.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 30 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 22 set 2004
    Consegnato il 01 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 september 2004
    Brevi particolari
    The basement, ground and first floor above ground premises at 15 and 17 frederick street, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 lug 2004
    Consegnato il 22 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of a personal bond dated 8 july 2004
    Brevi particolari
    The property known as dunedin house, 25 ravelston terrace, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 14 mag 2004
    Consegnato il 15 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the leasehold property known as phase 1, britannia park, middlesbrough (title number CE132852).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 24 mar 2004
    Consegnato il 01 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over phase 1, britannia park, middlesbrough CE132852.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 09 feb 2004
    Consegnato il 18 feb 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due in terms of a personal bond dated 28 january 2004
    Brevi particolari
    The subjects known as 96 willowbank road, aberdeen...see mortgage document for full description.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 18 apr 2003
    Consegnato il 01 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    178, 180,182 & 186 trongate, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Graham Douglas Frost
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    Ricevitore amministrativo
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    J B Cartwright
    Erskine House
    68 - 73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Ricevitore amministrativo
    Erskine House
    68 - 73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0