CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED

CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC158880
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CITY INN LIMITED28 set 200028 set 2000
    FIRST STOP HOTELS LIMITED27 giu 199527 giu 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Nomina di Mr Raymond Annel Marquis come amministratore in data 22 nov 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Emma Jane Morton come amministratore in data 22 nov 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Panayot Kostadinov Vasilev come amministratore in data 22 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon David Austin Davies come amministratore in data 22 nov 2019

    1 pagineTM01

    Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato)

    8 pagineLIQ13(Scot)

    Cessazione della carica di John Khay-Yan Wong come amministratore in data 17 apr 2019

    1 pagineTM01

    Modifica dei dettagli di Mr Stephen Allen Schwarzman come persona con controllo significativo il 30 ott 2018

    2 paginePSC04

    Notifica di Stephen Allen Schwarzman come persona con controllo significativo il 30 ott 2018

    2 paginePSC01

    Nomina di Mr John Khay-Yan Wong come amministratore in data 03 gen 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gabriel Petersen come amministratore in data 03 gen 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 set 2016

    LRESSP

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 27 giu 2015

    23 pagineRP04AR01

    Bilancio annuale redatto al 27 giu 2016

    21 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 ago 2016

    Stato del capitale al 16 ago 2016

    • Capitale: GBP 101,053
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 25 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 27 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1588800029 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 26 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1588800030 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1588800028 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name04 mag 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 29 apr 2016

    RES15

    Nomina di Mr Panayot Kostadinov Vasilev come amministratore in data 14 apr 2016

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gabriel Petersen il 16 apr 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon David Austin Davies il 16 apr 2016

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Segretario
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione08334728
    175738460001
    MARQUIS, Raymond Annel
    St James' Square
    SW1Y 4LB London
    12
    United Kingdom
    Amministratore
    St James' Square
    SW1Y 4LB London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritish243770520001
    MORTON, Emma Jane
    St James' Square
    SW1Y 4LB London
    12
    United Kingdom
    Amministratore
    St James' Square
    SW1Y 4LB London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritish264422520001
    MCFARLANE, Pauline Anne
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Segretario
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    British52526750008
    PAIN, Fennigje
    C/O Axios Hospitality Real Estate Services Limited
    26 Worple Road Wimbledon
    SW19 4EE London
    First Floor Beacon House
    United Kingdom
    Segretario
    C/O Axios Hospitality Real Estate Services Limited
    26 Worple Road Wimbledon
    SW19 4EE London
    First Floor Beacon House
    United Kingdom
    169634590001
    SALMER, Gabriele
    c/o Burness Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Segretario
    c/o Burness Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    163370600001
    ORR MACQUEEN WS
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Segretario nominato
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    900000160001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Amministratore
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritish73849040001
    BRIANCE, Richard Henry
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Amministratore
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandBritish16636440001
    CRERAR, William Gunn
    13 Northumberland Street
    EH3 6LL Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    13 Northumberland Street
    EH3 6LL Edinburgh
    Midlothian
    British17957980002
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    DAVIES, Simon David Austin
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Amministratore
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    United KingdomBritish147210490001
    FISKEN, Gillian Claire
    North Park Terrace
    EH4 1DP Edinburgh
    6
    Amministratore
    North Park Terrace
    EH4 1DP Edinburgh
    6
    British128106370001
    GATELEY, Donald Kenneth
    Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Level 1,
    United Kingdom
    Amministratore
    Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Level 1,
    United Kingdom
    United KingdomBritish104442220001
    HEPBURN, Victor Alexander
    c/o Joint Ventures Equity, Lloyds Banking Group
    4th Floor
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Scotland
    Amministratore
    c/o Joint Ventures Equity, Lloyds Banking Group
    4th Floor
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Scotland
    ScotlandBritish161679840001
    HOOD, Lynn Catherine
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Amministratore
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    ScotlandBritish116713060003
    KANDRAC, Martin
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Amministratore
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    United KingdomSlovakian163382910001
    KATZ, Andrew
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Amministratore
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    United KingdomAmerican163382710002
    MACDONALD, Angus Duncan Forbes
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Amministratore
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandBritish93989850003
    MACDONALD, Angus Donald Mackintosh
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Amministratore
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    ScotlandBritish43780001
    MANBY, Peter
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Amministratore
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandBritish155467670001
    MATTHEWS, Janet
    4 Hoskyns Avenue
    Harley Warren
    WR4 0LL Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    4 Hoskyns Avenue
    Harley Warren
    WR4 0LL Worcester
    Worcestershire
    British53862640001
    MCFARLANE, Pauline Anne
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Amministratore
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    United KingdomBritish52526750008
    MCKIE, Gordon Robert
    c/o Axios Hospitality Real Estate Services Limited
    26 Worple Road
    Wimbledon
    SW19 4EE London
    First Floor Beacon House
    England
    Amministratore
    c/o Axios Hospitality Real Estate Services Limited
    26 Worple Road
    Wimbledon
    SW19 4EE London
    First Floor Beacon House
    England
    EnglandBritish155757550001
    NORTH, Michael John
    The Mill House
    Astwick
    SG5 4BJ Hertfordshire
    Amministratore
    The Mill House
    Astwick
    SG5 4BJ Hertfordshire
    British89984500001
    O'CONNOR, Huw
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Amministratore
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandBritish74283080002
    ORR, David James Macconnell
    c/o Burness Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Amministratore
    c/o Burness Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    EnglandBritish100937170004
    ORR, James Alexander Macconnell
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Amministratore
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    ScotlandBritish81233650001
    PETERSEN, Gabriel
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Amministratore
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    United KingdomBritish132466780002
    SHEARER, David James Buchanan
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Amministratore
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    United KingdomBritish161360020001
    SMITH OF GILMOREHILL, Elizabeth Margaret, Baroness Smith Of Gilmorehill
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Amministratore
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    ScotlandBritish43044700001
    STARN, William Robert
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Amministratore
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandAmerican154007330001
    VASILEV, Panayot Kostadinov
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Amministratore
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    United KingdomBulgarian206224490001
    WATSON, Stuart Iain
    Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Level 1,
    United Kingdom
    Amministratore
    Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Level 1,
    United Kingdom
    United KingdomBritish126792450001
    WONG, John Khay-Yan
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    EnglandBritish226216750001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Stephen Allen Schwarzman
    345 Park Avenue
    NY 10154
    New York
    The Blackstone Group Lp
    New York
    United States
    30 ott 2018
    345 Park Avenue
    NY 10154
    New York
    The Blackstone Group Lp
    New York
    United States
    No
    Nazionalità: American
    Paese di residenza: United States
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 gen 2015
    Consegnato il 27 gen 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Mint hotel (formerly city inn hotel) finnineston quay, glasgow GLA148962.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transazioni
    • 27 gen 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 dic 2014
    Consegnato il 24 dic 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land to the west of neville street and land lying to the north canal wharf, leeds. Title numbers WYK842997 and WYK877560. Also all other plots of land listed on schedule 2 of the instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transazioni
    • 24 dic 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 dic 2014
    Consegnato il 24 dic 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transazioni
    • 24 dic 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 22 set 2011
    Consegnato il 05 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Mint hotel (formerly the city inn hotel) finnieston quay glasgow gla 148962.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag
    Transazioni
    • 05 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 22 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement and deed of accession
    Creato il 15 set 2011
    Consegnato il 05 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag
    Transazioni
    • 05 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 22 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 15 set 2011
    Consegnato il 05 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag
    Transazioni
    • 05 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 22 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 08 dic 2009
    Consegnato il 10 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land to west of neville street, leeds WYK877560.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 21 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Legal charge
    Creato il 19 giu 2009
    Consegnato il 07 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    A lease of flat 107 millbank court, 24 john islip street, london and store room 107.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Legal charge
    Creato il 26 mar 2008
    Consegnato il 26 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Granary wharf, leeds WYK843001 WYK842997 including fixed charges and assignment.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Legal charge
    Creato il 10 gen 2007
    Consegnato il 11 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All that benefit of the chargors interest in the development agreement and all rights, titles, benefits and interests relating to the development agreement.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Legal charge
    Creato il 10 gen 2007
    Consegnato il 11 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage granary wharf, leeds WYK834117 and WYK651848 WYK724867 including fixed charges.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 31 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 2007
    Consegnato il 18 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over 39 crutched friars, london NGL749312.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 09 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The city inn hotel, finnieston quay, glasgow and ground at finnieston quay GLA148962.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Legal charge
    Creato il 08 dic 2006
    Consegnato il 19 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Flat 107, millbank court, 24 john islip street & store room 107, london NGL320667; 25 savage gardens, london LN27259; hotel site, 31 aytoun street, manchester MAN22824; 30 john islip street, london LN96333 NGL795620; the city inn hotel, 1 brunswick square, brindleyplace, birmingham WM729821; land at temple way, bristol BL65802.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Bond & floating charge
    Creato il 08 dic 2006
    Consegnato il 18 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Legal charge
    Creato il 07 nov 2006
    Consegnato il 09 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Leasehold property known as flat and store room 107, tenth floor, millbank court, 24 john islip street, london NGL320667.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 14 ott 2005
    Consegnato il 27 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 dic 2005Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 19 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 06 lug 2005
    Consegnato il 08 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all that freehold property known as 25 savage gardens, london (title number LN27259); fixed and floating charges over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 03 giu 2005
    Consegnato il 08 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all that leasehold land at piccadilly triangle demised by an underlease between piccadilly place trustee (no.1) limited and piccadilly place trustee (no.2) limited and city inn limited dated 2 june 2005; fixed and floating charges over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 27 mag 2004
    Consegnato il 09 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Hotel site, piccadilly triangle, manchester.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 18 apr 2001
    Consegnato il 20 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the property (land at john islip street, london); fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 17 ago 2000
    Consegnato il 01 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 set 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 17 ago 2000
    Consegnato il 01 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 set 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 07 ago 2000
    Consegnato il 10 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 ago 2000
    Consegnato il 15 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground at finnieston quay, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 set 2016Inizio della liquidazione
    27 dic 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0