ANGUS CHISHOLM LIMITED

ANGUS CHISHOLM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàANGUS CHISHOLM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC159609
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ANGUS CHISHOLM LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ANGUS CHISHOLM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Q Court
    3 Quality Street
    EH4 5BP Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ANGUS CHISHOLM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THIMBLERIG LIMITED09 ago 199509 ago 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di ANGUS CHISHOLM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per ANGUS CHISHOLM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 04 set 2020

    • Capitale: GBP 100
    3 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Cessazione della carica di Sarah Janet Habib come amministratore in data 18 ago 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    6 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2020 al 31 ott 2020

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2018

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 ago 2015

    Stato del capitale al 12 ago 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 ago 2014

    Stato del capitale al 11 ago 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ago 2013

    Stato del capitale al 09 ago 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2012

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ANGUS CHISHOLM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HABIB, Benyamin Naeem
    House
    Ropley
    SO24 0EB Alresford
    Ropley
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    House
    Ropley
    SO24 0EB Alresford
    Ropley
    Hampshire
    United Kingdom
    British4909020003
    HABIB, Benyamin Naeem
    House
    Ropley
    SO24 0EB Alresford
    Ropley
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    House
    Ropley
    SO24 0EB Alresford
    Ropley
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector4909020005
    HABIB, Benyamin Naeem
    40 Winchester Street
    SW1V 4NF London
    Segretario
    40 Winchester Street
    SW1V 4NF London
    British4909020002
    KOTTLER, Susan Elizabeth
    The Old Rectory
    Little Comberton
    WR10 3EP Pershore
    Worcestershire
    Segretario
    The Old Rectory
    Little Comberton
    WR10 3EP Pershore
    Worcestershire
    BritishCompany Director7353860001
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    42 Moray Place
    EH3 6BT Edinburgh
    Segretario
    42 Moray Place
    EH3 6BT Edinburgh
    39806250001
    HABIB, Benyamin Naeem
    40 Winchester Street
    SW1V 4NF London
    Amministratore
    40 Winchester Street
    SW1V 4NF London
    BritishProperty Developer4909020002
    HABIB, Sarah Janet
    House
    Ropley
    SO24 0EB Alresford
    Ropley
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    House
    Ropley
    SO24 0EB Alresford
    Ropley
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector66439050003
    KOTTLER, John Charles
    The Old Rectory
    Little Comberton
    WR10 3EP Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Little Comberton
    WR10 3EP Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritishProperty Developer7353870001
    KOTTLER, Susan Elizabeth
    The Old Rectory
    Little Comberton
    WR10 3EP Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Little Comberton
    WR10 3EP Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director7353860001
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    42 Moray Place
    EH3 6BT Edinburgh
    Amministratore
    42 Moray Place
    EH3 6BT Edinburgh
    39109430001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ANGUS CHISHOLM LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    J. K. L. Property Limited
    Little Comberton
    WR10 3EP Pershore
    Mulberry House
    Worcestershire
    England
    06 apr 2016
    Little Comberton
    WR10 3EP Pershore
    Mulberry House
    Worcestershire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione01292788
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    ANGUS CHISHOLM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 09 ott 2001
    Consegnato il 12 ott 2001
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Units 1-3 follyburn place, eliburn road, livingston, west lothian.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 12 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The spar shop, 200 montrose street, brechin.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    63-65 clerkhill road, peterhead, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Property known as victoria buildings, main street, alford.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The lewes, main street, fyvie.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop at station road, kemnay, aberdeenshire.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Mace store, 3 netherley place, ballater.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground lying to the northwest of burghmuir drive, inverurie.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    12 grant street, cullen.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1 sunnyside, kilmaurs, ayr.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground lying towards the western side of blairfield road, tradespark, nairn.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    219 holburn street, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    Fixed and floating charge
    Creato il 28 lug 1999
    Consegnato il 17 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Rental assignment
    Creato il 18 apr 1997
    Consegnato il 09 mag 1997
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    With full title guarantee,the company assigns absolutely to the bank the benefit of the rents in respect of the lease for the property at 173 and 175 widmore road,bromley.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    Rental assignment
    Creato il 18 apr 1997
    Consegnato il 09 mag 1997
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Rents over 132 beaver road,ashford,kent.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 18 apr 1997
    Consegnato il 09 mag 1997
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over 173-175 widmore road,bromley. See the mortgage charge document for full details.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 18 apr 1997
    Consegnato il 09 mag 1997
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over 132 beaverroad,ashford,kent. See the mortgage charge document for full details.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 15 feb 1996
    Consegnato il 22 feb 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due by way of rents by alldays stores limited - the lewes, main street, fyvie.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 03 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due by way of rents by alldays stores limited - alldays store, high street, kingussie.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 03 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due by way of rents by alldays stores limited - 24 high street, banff.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 03 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due by way of rents by alldays stores limited - 64/65 clerkhill road, peterhead.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 03 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due by way of rents of alldays stores limited - 12 grant street, cullen.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 03 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due by way of rents by alldays stores limited - alldays store, victoria buildings, main street, alford.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 03 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due by way of rents by alldays stores limited - alldays store, macdonald drive, lossiemouth.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 03 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due by way of rents by alldays stores limited - alldays store, burghmuir drive, inverurie.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0