THE CAMPSIES CENTRE CUMBERNAULD LIMITED
Panoramica
Nome della società | THE CAMPSIES CENTRE CUMBERNAULD LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC159848 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | No |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE CAMPSIES CENTRE CUMBERNAULD LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova THE CAMPSIES CENTRE CUMBERNAULD LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Civic Centre (Head Of Legal & Democratic) Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Scotland |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE CAMPSIES CENTRE CUMBERNAULD LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PACIFIC SHELF 651 LIMITED | 17 ago 1995 | 17 ago 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE CAMPSIES CENTRE CUMBERNAULD LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE CAMPSIES CENTRE CUMBERNAULD LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2021 | 19 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2020 | 18 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Civic Centre Motherwell ML1 1TW a Civic Centre (Head of Legal & Democratic) Windmillhill Street Motherwell ML1 1AB in data 10 dic 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Nomina di Mr Archie Henry Aitken come segretario in data 28 nov 2019 | 2 pagine | AP03 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2019 | 19 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Gerard John Gardiner come segretario in data 19 lug 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018 | 20 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017 | 19 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Thomas Jamieson Hyslop Fisher come amministratore in data 30 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Ms Catherine Johnston come amministratore in data 30 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Calum David Richard Currie come amministratore in data 30 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Ms Claire Barclay come amministratore in data 30 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Jean Reid Jones come amministratore in data 30 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Elizabeth Irvine come amministratore in data 30 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Stephanie Griffin come amministratore in data 30 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Stephen Grant come amministratore in data 30 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2017 con aggiornamenti | 28 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 18 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di THE CAMPSIES CENTRE CUMBERNAULD LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITKEN, Archie Henry | Segretario | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre (Head Of Legal & Democratic) Scotland | 265203280001 | |||||||
BARCLAY, Claire | Amministratore | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre (Head Of Legal & Democratic) Scotland | Scotland | Scottish | Councillor | 234440470001 | ||||
CURRIE, Calum David Richard | Amministratore | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre (Head Of Legal & Democratic) Scotland | United Kingdom | British | Councillor | 116275860003 | ||||
FISHER, Thomas Jamieson Hyslop | Amministratore | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre (Head Of Legal & Democratic) Scotland | Scotland | British | Councillor | 204589650001 | ||||
GRAHAM, Allan George | Amministratore | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre (Head Of Legal & Democratic) Scotland | Scotland | British | Councillor | 171814150001 | ||||
JOHNSTON, Catherine | Amministratore | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre (Head Of Legal & Democratic) Scotland | Scotland | Scottish | Councillor | 171870950001 | ||||
MASTERTON, Alan | Amministratore | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre (Head Of Legal & Democratic) Scotland | Scotland | Scottish | None | 171814910001 | ||||
GARDINER, Gerard John | Segretario | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre North Lanarkshire Scotland | 199101650001 | |||||||
KILGOUR, Walter Bottomley | Segretario | 88 Main Road Condorrat G67 4AY Cumbernauld | British | 48802980001 | ||||||
MURRAY, Margaret June | Segretario | Civic Centre Motherwell ML1 1TW | British | 120323040001 | ||||||
ROBERTSON, Ronald William Mcpherson | Segretario | Cumbernauld House G67 3JH Cumbernauld Scotland | British | 19282640001 | ||||||
MD SECRETARIES (EDINBURGH) LIMITED | Segretario | Pacific House 70 Wellington Street G2 6SB Glasgow | 43825370001 | |||||||
BARRIE, Thomas Myles | Amministratore | 3 Belmont Street Kilsyth G65 9UP Glasgow Lanarkshire | British | Councillor | 19234380001 | |||||
BROOKS, James | Amministratore | 39 Tweed Street ML5 4LH Coatbridge | Scotland | British | Councillor | 652100004 | ||||
CARRIGAN, Daniel, Councillor | Amministratore | 3 Avonhead Road Cumbernauld G67 4RA Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Councillor | 122150310001 | ||||
CEFFERTY, Charles Rennie | Amministratore | Civic Centre Motherwell ML1 1TW | Scotland | British | None | 96252430002 | ||||
COMBE, Craig | Amministratore | 12 Lomond Place Cumbernauld G67 4JP Glasgow Lanarkshire | British | Councillor | 265000001 | |||||
COYLE, James | Amministratore | 15 Oak Path ML1 4PT Holytown Lanarkshire | British | Councillor | 48802510001 | |||||
CURRAN, Harry | Amministratore | 81 Orbiston Drive ML4 2LX Bellshill Lanarkshire | British | Councillor | 48153080001 | |||||
DAWSON, John Alan | Amministratore | F2 6 Nelson Street EH3 6LG Edinburgh Midlothian | British | Professor | 19234440001 | |||||
DEVINE, George Cairns, Councillor | Amministratore | Civic Centre Motherwell ML1 1TW | United Kingdom | British | None | 62390320001 | ||||
GILCHRIST, Douglas Smith | Amministratore | 17a Clouden Road G67 2HY Cumbernauld North Lanarkshire | British | Retired | 56784210001 | |||||
GRANT, Stephen, Councillor | Amministratore | Civic Centre Motherwell ML1 1TW | United Kingdom | British | None | 115257180001 | ||||
GRANT, Stephen, Councillor | Amministratore | 27c Afton Road Kildrum G67 2DP Cumbernauld Lanarkshire | United Kingdom | British | Councillor | 115257180001 | ||||
GRIFFIN, Mark | Amministratore | Parkburn Road G65 9DG Kilsyth 31 North Lanarkshire | British | Councillor | 129227410001 | |||||
GRIFFIN, Stephanie | Amministratore | Civic Centre Motherwell ML1 1TW | Britain | British | None | 173871500002 | ||||
HOMER, William | Amministratore | 129 Torbrex Road Cumbernauld G67 2JY North Lanarkshire | British | Councillor | 90527400001 | |||||
IRVINE, Elizabeth | Amministratore | Civic Centre Motherwell ML1 1TW | Scotland | British | None | 171814340001 | ||||
JONES, Jean Reid, Councillor | Amministratore | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre Scotland | Scotland | Scottish | None | 85398690001 | ||||
LOCKETT, Patrick Gordon | Amministratore | Swindridgemuir KA24 4HJ Dalry Ayrshire | Scotland | British | Director | 19234390001 | ||||
MACLEOD, Suzanne Marie, Councillor | Amministratore | 9 Westray Road Cumbernauld G67 1NN Glasgow | British | Councillor | 61753360001 | |||||
MCCULLOCH, Barry | Amministratore | 11 Ben Venue Road Cumbernauld G68 9JE Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | Councillor | 65816300001 | ||||
MCELROY, Gerard | Amministratore | 24 Lomond Crescent Cumbernauld G67 4JJ North Lanarkshire | Scotland | British | Councillor | 90527340001 | ||||
MCGUIGAN, Henry Damian | Amministratore | 16 Milnwood Drive ML4 2RB Bellshill Lanarkshire | British | Councillor | 35761300001 | |||||
MCKENNA, Rosemary | Amministratore | 9 Westray Road Cumbernauld G67 1NN Glasgow Lanarkshire | British | District Councillor | 717560001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE CAMPSIES CENTRE CUMBERNAULD LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Lanarkshire Council | 06 apr 2016 | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre Lanarkshire Scotland | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0