LIVINGSTON STADIA MANAGEMENT LIMITED

LIVINGSTON STADIA MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLIVINGSTON STADIA MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC160235
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LIVINGSTON STADIA MANAGEMENT LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova LIVINGSTON STADIA MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Argyll Court
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Scotland
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LIVINGSTON STADIA MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LIVI NITE SPOT LIMITED25 set 200025 set 2000
    LIVINGSTON FOOTBALL CLUB SOCIAL CLUB LIMITED07 set 199507 set 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di LIVINGSTON STADIA MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LIVINGSTON STADIA MANAGEMENT LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per LIVINGSTON STADIA MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 17 dic 2015

    • Capitale: GBP 9,000,001.00
    4 pagineSH01

    Stato del capitale al 22 dic 2015

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 30 apr 2016

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Henry Sharp il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 22 ott 2015

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da Regency House Crossgates Road, Halbeath Dunfermline, Fife KY11 7EG a Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT in data 23 ott 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 set 2015

    Stato del capitale al 16 set 2015

    • Capitale: GBP 9,000,000
    SH01

    Soddisfazione dell'onere SC1602350011 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1602350012 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca SC1602350011, creata il 12 feb 2015

    19 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca SC1602350012, creata il 12 feb 2015

    16 pagineMR01

    Nomina di Mr Giles Sharp come amministratore in data 23 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Fitzsimmons come amministratore in data 12 dic 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di LIVINGSTON STADIA MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Segretario
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    147809080001
    LEWIS, Colin Edward
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesBritishDirector59395180001
    SHARP, Giles Henry
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishChartered Accountant194659450001
    CROMWELL, Elaine Jane
    2 Ladysmill Court
    KY12 7YD Dunfermline
    Fife
    Segretario
    2 Ladysmill Court
    KY12 7YD Dunfermline
    Fife
    British94470860001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishCompany Director75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    ODELL, Timothy Earnleigh
    51 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BL Hatfield
    Hertfordshire
    Segretario
    51 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BL Hatfield
    Hertfordshire
    IrishDirector57015200002
    RENTON, James
    28 Comely Bank
    PH2 7HU Perth
    Segretario
    28 Comely Bank
    PH2 7HU Perth
    British42059980002
    ANDERSON STRATHERN WS
    48 Castle Street
    EH2 3LX Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    48 Castle Street
    EH2 3LX Edinburgh
    Midlothian
    33516610001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Segretario
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    613080003
    CAMERON, William
    Broompark
    101 Liberton Drive
    EH16 6TH Edinburgh
    Amministratore
    Broompark
    101 Liberton Drive
    EH16 6TH Edinburgh
    BritishDirector15243740003
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector154997530001
    CLARK, Robert
    128 Crewe Crescent
    EH5 2JW Edinburgh
    Amministratore
    128 Crewe Crescent
    EH5 2JW Edinburgh
    BritishEngineering Manager34313630001
    CONNOLLY, Gerard
    8 Carsview Drive
    Bearsden
    G61 3NJ Glasgow
    Amministratore
    8 Carsview Drive
    Bearsden
    G61 3NJ Glasgow
    BritishArchitect61839280001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishSolicitor1267050001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director75350600002
    HUNTER, William Proven
    6 Murieston Green
    EH54 9EQ Livingston
    West Lothian
    Amministratore
    6 Murieston Green
    EH54 9EQ Livingston
    West Lothian
    BritishBuilding Contractor63930210001
    JOHNSTON, James Donnelly
    4 Glebe Crescent
    FK8 2JB Stirling
    Amministratore
    4 Glebe Crescent
    FK8 2JB Stirling
    ScotlandBritishDirector86842130001
    KEANE, Dominic
    1102 Aikenhead Road
    G44 5SW Glasgow
    Amministratore
    1102 Aikenhead Road
    G44 5SW Glasgow
    BritishDirector61178980001
    KERR, John Neilson
    48 North Castle Street
    EH2 3LX Edinburgh
    Scotland
    Amministratore
    48 North Castle Street
    EH2 3LX Edinburgh
    Scotland
    BritishSolicitor65694070002
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector102797820001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MASTERTON, Gavin George
    6 Coldingham Place
    Garvock Hill
    KY12 7XS Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    6 Coldingham Place
    Garvock Hill
    KY12 7XS Dunfermline
    Fife
    United KingdomBritishBanker663070001
    MORAN, Paul Anthony
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director96935230001
    MORTIMORE, Jon William
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCfo207729000002
    RENTON, James
    28 Comely Bank
    PH2 7HU Perth
    Amministratore
    28 Comely Bank
    PH2 7HU Perth
    BritishEngineer42059980002
    STUART, John Forester
    48 North Castle Street
    EH2 3LX Edinburgh
    Amministratore
    48 North Castle Street
    EH2 3LX Edinburgh
    BritishSolicitor38185130001
    WAKEFIELD, David
    228 Lanark Road
    ML11 9XN Hazelbank
    Amministratore
    228 Lanark Road
    ML11 9XN Hazelbank
    BritishDirector83490330001
    LSM (DIRECTOR) LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Amministratore
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    97884460001

    LIVINGSTON STADIA MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 feb 2015
    Consegnato il 19 feb 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transazioni
    • 19 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 feb 2015
    Consegnato il 19 feb 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transazioni
    • 19 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 08 gen 2013
    Consegnato il 10 gen 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at almondvale stadium road livingston MID106363.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    English security agreement
    Creato il 28 giu 2012
    Consegnato il 10 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Security is made with full title guarantee in accordance with the law of property please see form for details.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 28 giu 2012
    Consegnato il 09 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 14 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 08 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 04 mag 2004
    Consegnato il 15 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest in the lease between W.L.D.C. & meadowbank thistle F.C. limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 21 mar 2003
    Consegnato il 08 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Stadia Investment Group Limited
    Transazioni
    • 08 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 giu 2003Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 13 set 2001
    Consegnato il 20 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenant's interest in the lease over almondvale stadium, almondvale, livingston.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 set 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 03 ago 2001
    Consegnato il 10 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 giu 2003Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 16 dic 1996
    Consegnato il 06 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 06 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 24 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0