CENTROS MILLER 1999 LIMITED
Panoramica
Nome della società | CENTROS MILLER 1999 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC168068 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CENTROS MILLER LIMITED | 29 ott 1996 | 29 ott 1996 |
DMWS 276 LIMITED | 04 set 1996 | 04 set 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato) | 14 pagine | LIQ13(Scot) | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL a C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD in data 10 ott 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Paul Jonathan Goswell come amministratore in data 05 set 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Sutherland come amministratore in data 05 set 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Miller House 2 Lochside View Edinburgh Park Edinburgh EH12 9DH a 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL in data 25 gen 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 gen 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 gen 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Euan James Edward Haggerty come amministratore in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip Hartley Miller come amministratore in data 31 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Frederic Hewett come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOSWELL, Paul Jonathan | Amministratore | 3 Scarth Road Barnes SW13 0ND London Westcott House United Kingdom | England | British | Director | 202597650001 | ||||
HADEN-SCOTT, Timothy | Amministratore | Lansdowne House Berkeley Square W1J 6ER London Delancey 6th Floor United Kingdom | England | British | Company Director | 133382310002 | ||||
MILLOY, David Thomas | Amministratore | Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh C/O Mazars Llp | Scotland | British | Director | 76474600001 | ||||
SUTHERLAND, Andrew | Amministratore | Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh C/O Mazars Llp | United Kingdom | British | Director Of Property Development | 66368290003 | ||||
DONALDSON, Euan James | Segretario | Woodburn Garvald EH41 4LN Haddington East Lothian | British | 41273760001 | ||||||
SMYTH, Pamela June | Segretario | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | British | 65057960002 | ||||||
DM COMPANY SERVICES LIMITED | Segretario nominato | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | 900000320001 | |||||||
ANDERSON, Philip Edward | Amministratore | 13 The Priory RH9 8NL Godstone Surrey | British | Chartered Surveyor | 14687720001 | |||||
BORLAND, Donald William | Amministratore | 408 Ferry Road EH5 2AD Edinburgh | United Kingdom | British | Accountant | 66010670002 | ||||
BRUCE, Roderick Lawrence | Amministratore delegato nominato | Rosehill 23 Inveresk Village Inveresk East Lothian | British | 900003110001 | ||||||
FROST, Simon | Amministratore | 32 Sidney Road KT12 2LZ Walton On Thames Surrey | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 16522420002 | ||||
HAGGERTY, Euan James Edward | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | United Kingdom | British | None | 162679260001 | ||||
HAMPSON, Lester Paul | Amministratore | 21 Brassey Hill RH8 0ES Oxted Surrey | British | Development Director | 97665250001 | |||||
HARRIS, Nicholas John | Amministratore | Evenlode,248 Station Road B93 0ES Knowle West Midlands | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 74890900001 | ||||
HARRIS, Nicholas John | Amministratore | Evenlode,248 Station Road B93 0ES Knowle West Midlands | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 74890900001 | ||||
HEWETT, Frederic Mark | Amministratore | 16 The Drive TN9 2LP Tonbridge Kent | United Kingdom | British | Company Director | 52840680001 | ||||
JACKSON, Julie Mansfield | Amministratore | 31 Inverleith Gardens EH3 5PR Edinburgh | United Kingdom | British | Solicitor | 94193070001 | ||||
LAKER, John Frederick | Amministratore | 57 Greenways KT10 0QH Hinchley Woods Surrey | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 54651510001 | ||||
MARSH, John Charles | Amministratore | 115 Upper Grosvenor Road TN1 2EA Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Development Director | 85346010001 | ||||
MILLER, Philip Hartley | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | Chartered Surveyor | 28512070005 | ||||
MINTO, Bruce Watson | Amministratore delegato nominato | 1 Wester Coates Road EH12 5LU Edinburgh | British | 900000330001 | ||||||
O'REILLY-NEENAN, Marie Bernadette | Amministratore | Ballymulcashel Kilmurry Sixmilebridge Ballymul House Ennis Co Clare Ireland | Irish | Finance Director | 135305100001 | |||||
ROBINSON, David | Amministratore | 118 Meadowspot EH10 5UY Edinburgh Lothian | Scotland | United Kingdom | Chartered Surveyor | 50541770001 | ||||
SUTHERLAND, Andrew | Amministratore | 87 Whitehouse Road EH4 6PB Edinburgh Lothian | United Kingdom | British | Director Of Property Develop. | 66368290001 | ||||
WHEELER, John Allan Campbell | Amministratore | 23 South Square NW11 7AJ London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 7882570001 | ||||
WISE, Richard John | Amministratore | 6 The Leas Longdean Park HP3 8BP Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 59140110002 | ||||
WOOD, Marlene | Amministratore | 15 Ormidale Terrace EH12 6DY Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 31152030002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CENTROS MILLER 1999 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centros Miller Holdings Limited | 06 apr 2016 | 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Miller House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CENTROS MILLER 1999 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Security document | Creato il 12 mag 2003 Consegnato il 30 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Land & buildings at wide bargate, threadneedle street, pen street, main ridge west and mitre lane, boston, lincolnshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage of deposited monies | Creato il 04 gen 2000 Consegnato il 17 gen 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari A book debt of £88,990 owing by hsbc bank PLC to centro miller limited standing to the credit of an interest earning bank account numbered 9246698 at hsbc bank PLC at its branch at holburn circus or such other account or accounts at any branch of hsbc bank PLC as may from time to time be submitted therefore whether by way of tranfer of monies redesignation or otherwise together with all further sums which may be credited to the account together with all interest accruing thereon and the due benefit and the advantage thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 18 nov 1996 Consegnato il 20 nov 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CENTROS MILLER 1999 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0