STRATHTAY VENTURES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | STRATHTAY VENTURES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC171237 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di STRATHTAY VENTURES LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova STRATHTAY VENTURES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 George Square G2 1AL Glasgow Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di STRATHTAY VENTURES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BRAVEHEART VENTURES LIMITED | 22 gen 1997 | 22 gen 1997 |
| NEWCO (507) LIMITED | 07 gen 1997 | 07 gen 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di STRATHTAY VENTURES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per STRATHTAY VENTURES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2019 | 23 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 77 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 gen 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Braveheart Investment Group Plc come persona con controllo significativo il 06 gen 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Gbac Limited come segretario in data 01 feb 2018 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Dundee Road Perth PH2 7DW a 1 George Square Glasgow G2 1AL in data 11 nov 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeremy Delmar-Morgan come amministratore in data 31 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 07 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Geoffrey Charles Byars Thomson come amministratore in data 19 nov 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Vivian David Hallam come amministratore in data 09 nov 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Merlin House Necessity Brae Perth PH2 0PF a 2 Dundee Road Perth PH2 7DW in data 22 giu 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Carolyn Smith come amministratore in data 06 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Aileen Brown come amministratore in data 20 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di STRATHTAY VENTURES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBAC LIMITED | Segretario | 83-85 Shambles Street S70 2SB Barnsley Old Linen Court England |
| 170866550001 | ||||||||||
| HALLAM, Vivian David | Amministratore | George Square G2 1AL Glasgow 1 Scotland | England | British | 91949990002 | |||||||||
| BALFOUR, Alan John | Segretario | Carpow House KY14 6EN Newburgh Fife | British | 949930002 | ||||||||||
| BROWN, Aileen | Segretario | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House United Kingdom | 166522140001 | |||||||||||
| GRANT, Colin Craigie | Segretario | The Cherrybank Centre Cherrybank Gardens PH2 0PF Perth | British | 188230360001 | ||||||||||
| SMITH, Carolyn | Segretario | 2/3, 2 Walmer Crescent G51 1AT Glasgow | British | 90876900001 | ||||||||||
| THOMSON, Geoffrey Charles Byars | Segretario | Thorngreen Farm PH2 6HW Kinrossie By Perth | British | 18668020001 | ||||||||||
| THOMSON, William Gordon | Segretario | Easter Caputh Farm Cottage Murthly PH1 4LA Perthshire | British | 96912680001 | ||||||||||
| THREIPLAND, Andrew Murray | Segretario | Fingask PH2 7SA Rait Perthshire | British | 11753830002 | ||||||||||
| MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 39 Castle Street EH2 3BH Edinburgh | 42680350001 | |||||||||||
| BALFOUR, Alan John | Amministratore | Carpow House KY14 6EN Newburgh Fife | Scotland | British | 949930002 | |||||||||
| BAXTER, Edward Thomas | Amministratore | Gilston KY8 5QP Leven Fife | Scotland | British | 36600150001 | |||||||||
| BENSON, Matthew James | Amministratore | The Coach House Balgone EH39 5BP North Berwick East Lothian | British | 30332650003 | ||||||||||
| BOGGS, Peter Lawson | Amministratore | 2 Cheyne Walk Chelsea SW3 5QZ London | American | 72417090001 | ||||||||||
| BROWN, Aileen | Amministratore | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House United Kingdom | Scotland | British | 135871560003 | |||||||||
| BROWN, John Kenneth | Amministratore | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House United Kingdom | Scotland | British | 462890004 | |||||||||
| CAMPBELL, Kenneth James | Amministratore | 123 Craigentinny Avenue EH7 6RG Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 842260002 | |||||||||
| CAMPBELL FRASER, Patrick Alexander | Amministratore | Borthwickshiels TD9 7LS Hawick Scottish Borders Scotland | Scotland | British | 49441240001 | |||||||||
| CUNNINGHAM, Edward Brandwood | Amministratore | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House United Kingdom | United Kingdom | British | 376910001 | |||||||||
| DELMAR-MORGAN, Jeremy | Amministratore | Dundee Road PH2 7DW Perth 2 Scotland | United Kingdom | British | 23953030001 | |||||||||
| GRANT, Colin Craigie | Amministratore | The Cherrybank Centre Cherrybank Gardens PH2 0PF Perth | United Kingdom | British | 188230360001 | |||||||||
| HUGHES, James Michael | Amministratore | Kerseland Crook Of Devon KY13 0UL Kinross Kinross Shire | Scotland | British | 107865020001 | |||||||||
| MACASKILL, Alistair Angus | Amministratore | Beech Hill Beech Hill Road Coupar Angus PH13 9AZ Blairgowrie Perthshire | British | 49154730001 | ||||||||||
| MACPHERSON, Agnes Lawrie Addie Shonaig | Amministratore | Lochcote EH49 6QE Linlithgow West Lothian | United Kingdom | British | 104298000001 | |||||||||
| SMITH, Carolyn | Amministratore | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House United Kingdom | United Kingdom | British | 90876900001 | |||||||||
| STEWART, Robert Douglas | Amministratore | Hilton Of Gask PH3 1HN Auchterarder Perthshire | British | 51913570002 | ||||||||||
| THOMSON, Geoffrey Charles Byars | Amministratore | Dundee Road PH2 7DW Perth 2 Scotland | Perth | British | 18668020001 | |||||||||
| THOMSON, William Gordon | Amministratore | Easter Caputh Farm Cottage Murthly PH1 4LA Perthshire | United Kingdom | British | 96912680001 | |||||||||
| THREIPLAND, Andrew Murray | Amministratore | Fingask PH2 7SA Rait Perthshire | United Kingdom | British | 11753830002 | |||||||||
| TURNER, Donald Ian | Amministratore | 10 The Glebe KA1 5PF Symington Ayrshire | Scotland | British | 172904550001 | |||||||||
| WATSON, Garry Sanderson | Amministratore | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House United Kingdom | England | British | 34442460001 | |||||||||
| WATSON, Garry Sanderson | Amministratore | Newlandburn House Newlandrig EH23 4NS Gorebridge Midlothian | England | British | 34442460001 | |||||||||
| WEMYSS, Charles John | Amministratore | Hill Of Invermay PH2 9DA Forgandenny Perthshire | United Kingdom | British | 732870002 | |||||||||
| WEMYSS, Michael James | Amministratore | Wemyss Castle KY1 4TE Fife | United Kingdom | British | 227540002 | |||||||||
| MBM BOARD NOMINEES LIMITED | Amministratore | 39 Castle Street EH2 3BH Edinburgh Midlothian | 42680340001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di STRATHTAY VENTURES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braveheart Investment Group Plc | 06 apr 2016 | George Square G2 1AL Glasgow 1 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
STRATHTAY VENTURES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creato il 21 mar 2001 Consegnato il 09 apr 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0