STRATHTAY VENTURES LIMITED

STRATHTAY VENTURES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTRATHTAY VENTURES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC171237
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 George Square
    G2 1AL Glasgow
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRAVEHEART VENTURES LIMITED22 gen 199722 gen 1997
    NEWCO (507) LIMITED07 gen 199707 gen 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2019

    23 pagineAA

    legacy

    77 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 gen 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Braveheart Investment Group Plc come persona con controllo significativo il 06 gen 2019

    2 paginePSC05

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    25 pagineAA

    Nomina di Gbac Limited come segretario in data 01 feb 2018

    2 pagineAP04

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Dundee Road Perth PH2 7DW a 1 George Square Glasgow G2 1AL in data 11 nov 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    24 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    24 pagineAA

    Cessazione della carica di Jeremy Delmar-Morgan come amministratore in data 31 lug 2016

    1 pagineTM01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 07 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 gen 2016

    Stato del capitale al 08 gen 2016

    • Capitale: GBP 1,939,190
    SH01

    Cessazione della carica di Geoffrey Charles Byars Thomson come amministratore in data 19 nov 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    27 pagineAA

    Nomina di Mr Vivian David Hallam come amministratore in data 09 nov 2015

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Merlin House Necessity Brae Perth PH2 0PF a 2 Dundee Road Perth PH2 7DW in data 22 giu 2015

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Carolyn Smith come amministratore in data 06 mag 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Aileen Brown come amministratore in data 20 apr 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GBAC LIMITED
    83-85 Shambles Street
    S70 2SB Barnsley
    Old Linen Court
    England
    Segretario
    83-85 Shambles Street
    S70 2SB Barnsley
    Old Linen Court
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04246760
    170866550001
    HALLAM, Vivian David
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    Amministratore
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    EnglandBritish91949990002
    BALFOUR, Alan John
    Carpow House
    KY14 6EN Newburgh
    Fife
    Segretario
    Carpow House
    KY14 6EN Newburgh
    Fife
    British949930002
    BROWN, Aileen
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Segretario
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    166522140001
    GRANT, Colin Craigie
    The Cherrybank Centre
    Cherrybank Gardens
    PH2 0PF Perth
    Segretario
    The Cherrybank Centre
    Cherrybank Gardens
    PH2 0PF Perth
    British188230360001
    SMITH, Carolyn
    2/3, 2 Walmer Crescent
    G51 1AT Glasgow
    Segretario
    2/3, 2 Walmer Crescent
    G51 1AT Glasgow
    British90876900001
    THOMSON, Geoffrey Charles Byars
    Thorngreen Farm
    PH2 6HW Kinrossie By Perth
    Segretario
    Thorngreen Farm
    PH2 6HW Kinrossie By Perth
    British18668020001
    THOMSON, William Gordon
    Easter Caputh Farm Cottage
    Murthly
    PH1 4LA Perthshire
    Segretario
    Easter Caputh Farm Cottage
    Murthly
    PH1 4LA Perthshire
    British96912680001
    THREIPLAND, Andrew Murray
    Fingask
    PH2 7SA Rait
    Perthshire
    Segretario
    Fingask
    PH2 7SA Rait
    Perthshire
    British11753830002
    MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Segretario
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    42680350001
    BALFOUR, Alan John
    Carpow House
    KY14 6EN Newburgh
    Fife
    Amministratore
    Carpow House
    KY14 6EN Newburgh
    Fife
    ScotlandBritish949930002
    BAXTER, Edward Thomas
    Gilston
    KY8 5QP Leven
    Fife
    Amministratore
    Gilston
    KY8 5QP Leven
    Fife
    ScotlandBritish36600150001
    BENSON, Matthew James
    The Coach House
    Balgone
    EH39 5BP North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    The Coach House
    Balgone
    EH39 5BP North Berwick
    East Lothian
    British30332650003
    BOGGS, Peter Lawson
    2 Cheyne Walk
    Chelsea
    SW3 5QZ London
    Amministratore
    2 Cheyne Walk
    Chelsea
    SW3 5QZ London
    American72417090001
    BROWN, Aileen
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Amministratore
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    ScotlandBritish135871560003
    BROWN, John Kenneth
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Amministratore
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    ScotlandBritish462890004
    CAMPBELL, Kenneth James
    123 Craigentinny Avenue
    EH7 6RG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    123 Craigentinny Avenue
    EH7 6RG Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish842260002
    CAMPBELL FRASER, Patrick Alexander
    Borthwickshiels
    TD9 7LS Hawick
    Scottish Borders
    Scotland
    Amministratore
    Borthwickshiels
    TD9 7LS Hawick
    Scottish Borders
    Scotland
    ScotlandBritish49441240001
    CUNNINGHAM, Edward Brandwood
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Amministratore
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    United KingdomBritish376910001
    DELMAR-MORGAN, Jeremy
    Dundee Road
    PH2 7DW Perth
    2
    Scotland
    Amministratore
    Dundee Road
    PH2 7DW Perth
    2
    Scotland
    United KingdomBritish23953030001
    GRANT, Colin Craigie
    The Cherrybank Centre
    Cherrybank Gardens
    PH2 0PF Perth
    Amministratore
    The Cherrybank Centre
    Cherrybank Gardens
    PH2 0PF Perth
    United KingdomBritish188230360001
    HUGHES, James Michael
    Kerseland
    Crook Of Devon
    KY13 0UL Kinross
    Kinross Shire
    Amministratore
    Kerseland
    Crook Of Devon
    KY13 0UL Kinross
    Kinross Shire
    ScotlandBritish107865020001
    MACASKILL, Alistair Angus
    Beech Hill Beech Hill Road
    Coupar Angus
    PH13 9AZ Blairgowrie
    Perthshire
    Amministratore
    Beech Hill Beech Hill Road
    Coupar Angus
    PH13 9AZ Blairgowrie
    Perthshire
    British49154730001
    MACPHERSON, Agnes Lawrie Addie Shonaig
    Lochcote
    EH49 6QE Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    Lochcote
    EH49 6QE Linlithgow
    West Lothian
    United KingdomBritish104298000001
    SMITH, Carolyn
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Amministratore
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    United KingdomBritish90876900001
    STEWART, Robert Douglas
    Hilton Of Gask
    PH3 1HN Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    Hilton Of Gask
    PH3 1HN Auchterarder
    Perthshire
    British51913570002
    THOMSON, Geoffrey Charles Byars
    Dundee Road
    PH2 7DW Perth
    2
    Scotland
    Amministratore
    Dundee Road
    PH2 7DW Perth
    2
    Scotland
    PerthBritish18668020001
    THOMSON, William Gordon
    Easter Caputh Farm Cottage
    Murthly
    PH1 4LA Perthshire
    Amministratore
    Easter Caputh Farm Cottage
    Murthly
    PH1 4LA Perthshire
    United KingdomBritish96912680001
    THREIPLAND, Andrew Murray
    Fingask
    PH2 7SA Rait
    Perthshire
    Amministratore
    Fingask
    PH2 7SA Rait
    Perthshire
    United KingdomBritish11753830002
    TURNER, Donald Ian
    10 The Glebe
    KA1 5PF Symington
    Ayrshire
    Amministratore
    10 The Glebe
    KA1 5PF Symington
    Ayrshire
    ScotlandBritish172904550001
    WATSON, Garry Sanderson
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    Amministratore
    Necessity Brae
    PH2 0PF Perth
    Merlin House
    United Kingdom
    EnglandBritish34442460001
    WATSON, Garry Sanderson
    Newlandburn House Newlandrig
    EH23 4NS Gorebridge
    Midlothian
    Amministratore
    Newlandburn House Newlandrig
    EH23 4NS Gorebridge
    Midlothian
    EnglandBritish34442460001
    WEMYSS, Charles John
    Hill Of Invermay
    PH2 9DA Forgandenny
    Perthshire
    Amministratore
    Hill Of Invermay
    PH2 9DA Forgandenny
    Perthshire
    United KingdomBritish732870002
    WEMYSS, Michael James
    Wemyss Castle
    KY1 4TE Fife
    Amministratore
    Wemyss Castle
    KY1 4TE Fife
    United KingdomBritish227540002
    MBM BOARD NOMINEES LIMITED
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Midlothian
    42680340001

    Chi sono le persone con controllo significativo di STRATHTAY VENTURES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Braveheart Investment Group Plc
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    06 apr 2016
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act 2006 Scottish Law
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies Scotland
    Numero di registrazioneSc247376
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    STRATHTAY VENTURES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond & floating charge
    Creato il 21 mar 2001
    Consegnato il 09 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0