MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC173710 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Brodies Llp 15 Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jonathan David Forster il 31 mar 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Elizabeth Ann Horlock Clarke il 31 mar 2020 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ocean Point 1st Floor, 94 Ocean Drive Edinburgh EH6 6JH United Kingdom a C/O Brodies Llp 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA in data 11 mar 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Morrison (Oldco) Limited come persona con controllo significativo il 11 mar 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Wave Holdings Limited come persona con controllo significativo il 26 set 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ocean Point 1st Floor, Ocean 94 Ocean Drive Edinburgh Eh6 6 Jh United Kingdom a Ocean Point 1st Floor, 94 Ocean Drive Edinburgh EH6 6JH in data 18 gen 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 47 Melville Street Edinburgh EH3 7HL a Ocean Point 1st Floor, Ocean 94 Ocean Drive Edinburgh Eh6 6 Jh in data 18 gen 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Claire Tytherleigh Russell come amministratore in data 28 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Elizabeth Ann Horlock Clarke come amministratore in data 28 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Elizabeth Ann Horlock Clarke come amministratore in data 01 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Claire Tytherleigh Russell come amministratore in data 30 nov 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Geoffrey Arthur George Shepheard come segretario in data 31 mar 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Elizabeth Ann Horlock | Segretario | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | 198551370001 | |||||||
| FORSTER, Jonathan David | Amministratore | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House United Kingdom | United Kingdom | British | 101812460002 | |||||
| RUSSELL, Claire Tytherleigh | Amministratore | 15 Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh C/O Brodies Llp Scotland | England | British | 105433380001 | |||||
| FOX, Jacqueline Elizabeth | Segretario | Little Dormers 3 Wicken Road CB11 3QD Newport Essex | British | 35460890004 | ||||||
| GILLEN, Seamus Joseph | Segretario | 20 Mountway EN6 1EP Potters Bar Hertfordshire | British | 66174560001 | ||||||
| MORRISON, John | Segretario | Willis Mar 13 Glen Brae FK1 5LT Falkirk Central Scotland | British | 1500260013 | ||||||
| SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Segretario | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||
| TURNER, David Charles | Segretario | 13 Thorndales St Johns Avenue CM14 5DE Brentwood Essex | Other | 84007940001 | ||||||
| ANDERSON, Mark Stephen | Amministratore | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | England | British | 122463830003 | |||||
| CLARKE, Elizabeth Ann Horlock | Amministratore | Melville Street EH3 7HL Edinburgh 47 | United Kingdom | British | 203580340001 | |||||
| FIRTH, Patrick | Amministratore | The Cottage High Street PE28 0AB Ellington Huntingdon Cambs | British | 85034900001 | ||||||
| FORSTER, Jonathan David | Amministratore | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | United Kingdom | British | 101812460002 | |||||
| GREEN, Robert David | Amministratore | 1a Burnside Road White Craigs G46 6TT Glasgow | British | 76720550002 | ||||||
| HAMPSON, Michael David | Amministratore | Anglian House Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Cambs | British | 105084640001 | ||||||
| HOWELL, Keith Martin | Amministratore | Lynehurst Carlops Road EH46 7DS West Linton Peeblesshire | British | 1499960006 | ||||||
| LAWSON, Robin Patrick | Amministratore | 8 Drumsheugh Gardens EH3 7QJ Edinburgh | British | 11071830002 | ||||||
| MACLENNAN, Norman Angus | Amministratore | Croft Na Coille 25 Toberargan Road PH16 5HG Pitlochry Perthshire | British | 75374210001 | ||||||
| MORRISON, John | Amministratore | Willis Mar 13 Glen Brae FK1 5LT Falkirk Central Scotland | British | 1500260013 | ||||||
| NILSSON, Lars Ingvar | Amministratore | Stora Fiskaregatan 9e S 222 24 Lund FOREIGN Sweden | Swedish | 76837160001 | ||||||
| POPLE, David George | Amministratore | 120 Stanley Street AB10 6UQ Aberdeen Aberdeenshire | British | 53727020004 | ||||||
| RUSSELL, Claire Tytherleigh | Amministratore | Melville Street EH3 7HL Edinburgh 47 | England | British | 105433380001 | |||||
| SIMS, Christopher John | Amministratore | Chartmoor Chart Lane Brasted Chart TN16 1LU Westerham Kent | British | 51887190001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Amministratore | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | England | British | 135181230001 | |||||
| WARRACK, Anne Victoria Mary | Amministratore | The White Cottage 153 Bridge Street, Whddon SG8 5SP Royston Herts | United Kingdom | British | 123157220001 | |||||
| WATSON, Derek | Amministratore | 68 Woodvale Coulby Newham TS8 0SJ Middlesbrough Cleveland | England | British | 6396340001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrison (Oldco) Limited | 06 apr 2016 | 15 Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh C/O Brodies Llp Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MORRISON INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creato il 17 lug 1997 Consegnato il 01 ago 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole of the property. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 18 giu 1997 Consegnato il 25 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0