ST ANDREW LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàST ANDREW LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC177533
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ST ANDREW LIMITED?

    • (4521) /

    Dove si trova ST ANDREW LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Regency House Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Fife
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ST ANDREW LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BERKELEY ST ANDREW PUBLIC LIMITED COMPANY25 lug 199725 lug 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di ST ANDREW LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ST ANDREW LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Transfer of all interest in certain properties 14/12/2011
    RES13

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 15 dic 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Norman Yardley il 08 lug 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Norman Yardley come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 25 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di David Gaffney come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Nomina di Mr Colin Edward Lewis come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Neil Fitzsimmons come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 29 gen 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Dominic Lavelle come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ST ANDREW LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808800001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    YARDLEY, Norman
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector153904770001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MACLENNAN, Angus
    Wellfield Cottage
    32 Muirpark
    EH22 3JD Dalkeith
    Midlothian
    Segretario
    Wellfield Cottage
    32 Muirpark
    EH22 3JD Dalkeith
    Midlothian
    British65238670001
    MILLER, Alasdair James
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    Segretario
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    British200739750001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Segretario
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    BritishDirector78545300002
    PARSLIFFE, Andrew John
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    Segretario
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    British67033440002
    PUTTERGILL, Claire
    18 Alfred Road
    KT1 2UA Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    18 Alfred Road
    KT1 2UA Kingston Upon Thames
    Surrey
    British49527970003
    ANDERSON STRATHERN WS
    48 Castle Street
    EH2 3LX Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    48 Castle Street
    EH2 3LX Edinburgh
    Midlothian
    33516610001
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Segretario
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Segretario nominato
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    BROWN, Andrew
    5 Strathcarron Way
    PA2 7AE Paisley
    Renfrewshire
    Amministratore
    5 Strathcarron Way
    PA2 7AE Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandScottishTechnical Director91209410001
    COSTER, Gordon Knox
    Mossdale
    East Kilbride
    G74 4JG Glasgow
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    Mossdale
    East Kilbride
    G74 4JG Glasgow
    6
    United Kingdom
    BritishManaging Director132919070001
    CROOK, James
    34 Barnton Park Crescent
    EH4 6EP Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    34 Barnton Park Crescent
    EH4 6EP Edinburgh
    Midlothian
    BritishTechnical Director67105710001
    DAVIDSON, Iain Cameron
    8 Calderstones Drive
    Whalley
    BB7 9JB Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    8 Calderstones Drive
    Whalley
    BB7 9JB Clitheroe
    Lancashire
    EnglandBritishSales Director95642050001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    DOWNIE, David
    6 Ellersley Manor
    60 Campbell Avenue
    EH12 6DN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    6 Ellersley Manor
    60 Campbell Avenue
    EH12 6DN Edinburgh
    Midlothian
    BritishConstruction Director67105390001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    GUEST, Robin Martin
    Summerlea Ferntower Road
    PH7 3DH Crieff
    Perthshire
    Amministratore
    Summerlea Ferntower Road
    PH7 3DH Crieff
    Perthshire
    BritishManaging Director18510650002
    HUTCHINSON, Geoffrey
    Rectory Lodge
    Kyre
    WR15 8RW Tenbury Wells
    Worcestershire
    Amministratore
    Rectory Lodge
    Kyre
    WR15 8RW Tenbury Wells
    Worcestershire
    United KingdomBritishCompany Director16644000004
    JACOBS, John Richard
    12 Priory Quay
    Quay Road
    BH23 1DR Christchurch
    Dorset
    Amministratore
    12 Priory Quay
    Quay Road
    BH23 1DR Christchurch
    Dorset
    BritishGroup Director64717470001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    LEITCH, Gerald
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    Amministratore
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    BritishCommercial Director110231420001
    LEWIS, Roger St John Hulton
    Lower Mole House
    Tilt Road
    KT11 3HS Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Lower Mole House
    Tilt Road
    KT11 3HS Cobham
    Surrey
    BritishDirector30879310002
    MACLENNAN, Angus
    Wellfield Cottage
    32 Muirpark
    EH22 3JD Dalkeith
    Midlothian
    Amministratore
    Wellfield Cottage
    32 Muirpark
    EH22 3JD Dalkeith
    Midlothian
    BritishFinance Director65238670001
    MACLEOD, Angus Iain
    81 Fereneze Avenue
    Clarkston
    G76 7RX Glasgow
    Amministratore
    81 Fereneze Avenue
    Clarkston
    G76 7RX Glasgow
    ScotlandBritishDirector57667380001
    MAXWELL, Clive
    12 Brairhill Avenue
    Dalgety Bay
    KY11 9UR Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    12 Brairhill Avenue
    Dalgety Bay
    KY11 9UR Dunfermline
    Fife
    BritishTechnical Director122157390001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    138 King Charles Road
    KT5 8QN Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    138 King Charles Road
    KT5 8QN Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant1571200001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Amministratore
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    United KingdomBritishAccountant78545300002
    O'CALLAGHAN, Sean James
    3 Golf Place
    DD8 4TY Kirriemuir
    Angus
    Amministratore
    3 Golf Place
    DD8 4TY Kirriemuir
    Angus
    BritishManaging Director Designate101412420001
    PUNLER, Keith Arthur
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    Amministratore
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    ScotlandBritishChartered Surveyor142078700006

    ST ANDREW LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 14 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 08 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due all sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 13 apr 2004
    Consegnato il 21 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    3.87 hectares on south side of windygates road, north berwick ELN226 under exception.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 13 apr 2004
    Consegnato il 21 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground north of dalry road, edinburgh & south of distillery lane, haymarket, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 13 apr 2004
    Consegnato il 21 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Phase 1 of the development at kip village, inverkip, greenock REN105133 under exception.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Floating charge
    Creato il 05 apr 2004
    Consegnato il 16 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 10 nov 2003
    Consegnato il 28 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Obligations pursuant to missives dated 2 march 2000 (as amended)
    Brevi particolari
    Phase 1C, kip village, inverkip, greenock.
    Persone aventi diritto
    • Holt Leisure Parks Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 11 giu 2001
    Consegnato il 15 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    163-167 ingram street and 92 glassford street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 11 giu 2001
    Consegnato il 15 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    159 ingram street and 97-101 hutcheson street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 11 giu 2001
    Consegnato il 15 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    1.5 acres at pollok castle estate, newton mearns.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 11 giu 2001
    Consegnato il 15 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    Phase I at kip village, inverkip.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 11 giu 2001
    Consegnato il 15 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    Windygates road, traynor's brae, north berwick.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 08 giu 2001
    Consegnato il 15 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    Power house, dalry road, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 08 giu 2001
    Consegnato il 15 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    Plots a and b, mount tabor road, perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 08 giu 2001
    Consegnato il 15 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    Subjects at coulter road, biggar, lanark.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 08 giu 2001
    Consegnato il 15 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    Units 3, 12, 17 and 18 bishops wood, dunblane, perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 08 giu 2001
    Consegnato il 15 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    Plot numbers 1 and 3 woodlea, dunblane, perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 25 mag 2001
    Consegnato il 31 mag 2001
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 26 feb 2001
    Consegnato il 12 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Obligations as contained in missives
    Brevi particolari
    Area of ground at kip village, inverkip, greenock.
    Persone aventi diritto
    • Holt Leisure Parks Limited
    Transazioni
    • 12 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0