ST ANDREW LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ST ANDREW LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC177533 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ST ANDREW LIMITED?
- (4521) /
Dove si trova ST ANDREW LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Regency House Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Fife |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ST ANDREW LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BERKELEY ST ANDREW PUBLIC LIMITED COMPANY | 25 lug 1997 | 25 lug 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ST ANDREW LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per ST ANDREW LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02s | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 15 dic 2011
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Norman Yardley il 08 lug 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Norman Yardley come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Gaffney come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Colin Edward Lewis come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Neil Fitzsimmons come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 29 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Dominic Lavelle come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ST ANDREW LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Segretario | Ridgeway Road RH1 6PQ Redhill 35 Surrey United Kingdom | 147808800001 | |||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050002 | |||||
| LEWIS, Colin Edward | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| YARDLEY, Norman | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 153904770001 | |||||
| GANDHI, Devendra | Segretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Segretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MACLENNAN, Angus | Segretario | Wellfield Cottage 32 Muirpark EH22 3JD Dalkeith Midlothian | British | 65238670001 | ||||||
| MILLER, Alasdair James | Segretario | 22 Beauly Crescent Newton Mearns G77 5UQ Glasgow | British | 200739750001 | ||||||
| MOTION, Michelle Hunter | Segretario | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | 78545300002 | ||||||
| PARSLIFFE, Andrew John | Segretario | 7 Dupplin Terrace PH2 7DG Perth Perthshire | British | 67033440002 | ||||||
| PUTTERGILL, Claire | Segretario | 18 Alfred Road KT1 2UA Kingston Upon Thames Surrey | British | 49527970003 | ||||||
| ANDERSON STRATHERN WS | Segretario | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh Midlothian | 33516610001 | |||||||
| BURNESS LLP | Segretario | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 99448920001 | |||||||
| BURNESS SOLICITORS | Segretario nominato | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900000240001 | |||||||
| BROWN, Andrew | Amministratore | 5 Strathcarron Way PA2 7AE Paisley Renfrewshire | Scotland | Scottish | 91209410001 | |||||
| COSTER, Gordon Knox | Amministratore | Mossdale East Kilbride G74 4JG Glasgow 6 United Kingdom | British | 132919070001 | ||||||
| CROOK, James | Amministratore | 34 Barnton Park Crescent EH4 6EP Edinburgh Midlothian | British | 67105710001 | ||||||
| DAVIDSON, Iain Cameron | Amministratore | 8 Calderstones Drive Whalley BB7 9JB Clitheroe Lancashire | England | British | 95642050001 | |||||
| DIPRE, Remo | Amministratore | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| DOWNIE, David | Amministratore | 6 Ellersley Manor 60 Campbell Avenue EH12 6DN Edinburgh Midlothian | British | 67105390001 | ||||||
| GAFFNEY, David | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Amministratore | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| GUEST, Robin Martin | Amministratore | Summerlea Ferntower Road PH7 3DH Crieff Perthshire | British | 18510650002 | ||||||
| HUTCHINSON, Geoffrey | Amministratore | Rectory Lodge Kyre WR15 8RW Tenbury Wells Worcestershire | United Kingdom | British | 16644000004 | |||||
| JACOBS, John Richard | Amministratore | 12 Priory Quay Quay Road BH23 1DR Christchurch Dorset | British | 64717470001 | ||||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Amministratore | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LEITCH, Gerald | Amministratore | 24 Mary Fisher Crescent G82 1BF Dumbarton Dunbartonshire | British | 110231420001 | ||||||
| LEWIS, Roger St John Hulton | Amministratore | Lower Mole House Tilt Road KT11 3HS Cobham Surrey | British | 30879310002 | ||||||
| MACLENNAN, Angus | Amministratore | Wellfield Cottage 32 Muirpark EH22 3JD Dalkeith Midlothian | British | 65238670001 | ||||||
| MACLEOD, Angus Iain | Amministratore | 81 Fereneze Avenue Clarkston G76 7RX Glasgow | Scotland | British | 57667380001 | |||||
| MAXWELL, Clive | Amministratore | 12 Brairhill Avenue Dalgety Bay KY11 9UR Dunfermline Fife | British | 122157390001 | ||||||
| MCARTHUR, Alexander Nigel | Amministratore | 138 King Charles Road KT5 8QN Surbiton Surrey | United Kingdom | British | 1571200001 | |||||
| MOTION, Michelle Hunter | Amministratore | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | United Kingdom | British | 78545300002 | |||||
| O'CALLAGHAN, Sean James | Amministratore | 3 Golf Place DD8 4TY Kirriemuir Angus | British | 101412420001 | ||||||
| PUNLER, Keith Arthur | Amministratore | Beaufield Middle Balado KY13 0NH Kinross Tayside | Scotland | British | 142078700006 |
ST ANDREW LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 30 dic 2008 Consegnato il 14 gen 2009 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 30 dic 2008 Consegnato il 08 gen 2009 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due all sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 13 apr 2004 Consegnato il 21 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 3.87 hectares on south side of windygates road, north berwick ELN226 under exception. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 13 apr 2004 Consegnato il 21 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Ground north of dalry road, edinburgh & south of distillery lane, haymarket, edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 13 apr 2004 Consegnato il 21 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Phase 1 of the development at kip village, inverkip, greenock REN105133 under exception. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 05 apr 2004 Consegnato il 16 apr 2004 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 10 nov 2003 Consegnato il 28 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Obligations pursuant to missives dated 2 march 2000 (as amended) | |
Brevi particolari Phase 1C, kip village, inverkip, greenock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 11 giu 2001 Consegnato il 15 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari 163-167 ingram street and 92 glassford street, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 11 giu 2001 Consegnato il 15 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari 159 ingram street and 97-101 hutcheson street, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 11 giu 2001 Consegnato il 15 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari 1.5 acres at pollok castle estate, newton mearns. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 11 giu 2001 Consegnato il 15 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari Phase I at kip village, inverkip. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 11 giu 2001 Consegnato il 15 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari Windygates road, traynor's brae, north berwick. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 08 giu 2001 Consegnato il 15 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari Power house, dalry road, edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 08 giu 2001 Consegnato il 15 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari Plots a and b, mount tabor road, perth. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 08 giu 2001 Consegnato il 15 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari Subjects at coulter road, biggar, lanark. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 08 giu 2001 Consegnato il 15 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari Units 3, 12, 17 and 18 bishops wood, dunblane, perth. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 08 giu 2001 Consegnato il 15 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari Plot numbers 1 and 3 woodlea, dunblane, perth. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 25 mag 2001 Consegnato il 31 mag 2001 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 26 feb 2001 Consegnato il 12 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Obligations as contained in missives | |
Brevi particolari Area of ground at kip village, inverkip, greenock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0