PENTLAND HEALTHCARE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PENTLAND HEALTHCARE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC184337 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PENTLAND HEALTHCARE LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova PENTLAND HEALTHCARE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP 249 West George Street G2 4RB Glasgow United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di PENTLAND HEALTHCARE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per PENTLAND HEALTHCARE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 24 lug 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Southern Cross Healthcare the Castle Business Park Lomond Court Ground Floor Unit 2 Stirling FK9 4TU Scotland in data 20 gen 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Mcleish come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Southern Cross Healthcare 199 Bath Street Glasgow G2 4HU in data 28 lug 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 27 set 2009 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Smith come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per William James Buchan il 27 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard Neil Midmer il 27 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PENTLAND HEALTHCARE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Amministratore | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| FEENEY, Martin | Segretario | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Segretario | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Segretario | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Segretario | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Segretario | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | 158305200001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Segretario | c/o Southern Cross Healthcare The Castle Business Park Lomond Court FK9 4TU Ground Floor Unit 2 Stirling Scotland | British | 168970640001 | ||||||
| ROACH, Paul Vyvyan | Segretario | 65 Greenfields Avenue Appleton WA4 3BW Warrington | British | 61280700002 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Segretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| DALGLEN SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | Dalmore House 310 St Vincent Street G2 5QR Glasgow Strathclyde | 900015270001 | |||||||
| ATWILL, Robert Frederick | Amministratore | 46 Saint Johns Avenue WA16 0DH Knutsford Cheshire | British | 61398460002 | ||||||
| BOLOT, Timothy James | Amministratore | c/o Dla Piper Scotland Llp West George Street G2 4RB Glasgow 249 United Kingdom | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BUCHAN, William James | Amministratore | c/o Southern Cross Healthcare The Castle Business Park Lomond Court FK9 4TU Ground Floor Unit 2 Stirling Scotland | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Amministratore | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| FEENEY, Martin | Amministratore | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Amministratore | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Amministratore | C/O Southern Cross Healthcare 199 Bath Street G2 4HU Glasgow | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Amministratore | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Amministratore | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Amministratore | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LOCK, Jason David | Amministratore | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MCINTEER, Warren Hill | Amministratore | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 100131200001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Amministratore | The Castle Business Park, Lomond Court Ground Floor, Unit 2 FK9 4TU Stirling C/O Southern Cross Healthcare Scotland Scotland | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Amministratore | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| ROACH, Paul Vyvyan | Amministratore | 65 Greenfields Avenue Appleton WA4 3BW Warrington | British | 61280700002 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Amministratore | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Amministratore | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Amministratore | c/o Southern Cross Healthcare The Castle Business Park Lomond Court FK9 4TU Ground Floor Unit 2 Stirling Scotland | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Amministratore | Durham Road Low Fell NE9 5AL Gateshead 377 England England | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| STOREY, John | Amministratore | 93 Dacre Park Blackheath SE13 5BX London | British | 60123860002 | ||||||
| DALGLEN DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | Dalmore House 310 St Vincent Street G2 5QR Glasgow Strathclyde | 900015260001 | |||||||
| DALGLEN SECRETARIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Dalmore House 310 St Vincent Street G2 5QR Glasgow Strathclyde | 900015270001 |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0