VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE

VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società SC187421
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?

    • Attività di altre organizzazioni di categoria n.c.a. (94990) / Altre attività di servizi

    Dove si trova VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?

    Indirizzo della sede legale
    Undercover
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    East Renfrewshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EAST RENFREWSHIRE COUNCIL FOR THE VOLUNTARY SECTOR07 lug 199807 lug 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Risoluzioni

    Resolutions
    7 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    The company hasbeen converted into a scio 10/09/2015
    RES13

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 06 lug 2015, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    7 pagineAR01

    Cessazione della carica di Angela Janet Mccormack come amministratore in data 14 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Angela Janet Mccormack come segretario in data 14 lug 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    32 pagineAA

    Nomina di Mr Donald Macrae Davidson come amministratore in data 24 set 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Angela Janet Mccormack come amministratore in data 14 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Angela Janet Mccormack come segretario in data 14 lug 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Doctor John Charles Dudgeon come amministratore in data 02 apr 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jacqueline Taylor Reid come amministratore in data 29 gen 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kenneth Stirling come amministratore in data 24 set 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Douglas Arthur Yates come amministratore in data 16 feb 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    33 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 lug 2014, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    9 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Jacqueline Reid Taylor il 31 mar 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Mrs Jacqueline Reid Taylor come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kenneth Greenhill come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lynn Tennent come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    30 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 lug 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    10 pagineAR01

    Memorandum e Statuto

    20 pagineMEM/ARTS

    Nomina di Mr Ross Christison Mckemmie come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Douglas Arthur Yates come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIDSON, Donald Macrae
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    Amministratore
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    Great BritainBritish199467480001
    DUDGEON, John Charles, Dr
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    Amministratore
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    ScotlandBritish198718260001
    KENNEDY, Anne Marie
    50 Levernside Avenue
    G78 1LW Barrhead
    East Renfrewshire
    Amministratore
    50 Levernside Avenue
    G78 1LW Barrhead
    East Renfrewshire
    ScotlandBritish99342790001
    MCDEVITT, Paul Charles
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    Amministratore
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    ScotlandBritish90653930001
    MCKEMMIE, Ross Christison
    Merrylee Crescent
    Giffnock
    G46 6AP Glasgow
    10
    Scotland
    Amministratore
    Merrylee Crescent
    Giffnock
    G46 6AP Glasgow
    10
    Scotland
    ScotlandBritish3217560001
    BIGHAM, Alan Jorge
    296 Burnfield Road
    G43 1EE Glasgow
    2/2
    United Kingdom
    Segretario
    296 Burnfield Road
    G43 1EE Glasgow
    2/2
    United Kingdom
    Other130616900001
    MCCORMACK, Angela Janet
    Langcraigs Drive
    PA2 8JP Paisley
    49
    Renfrewshire
    United Kingdom
    Segretario
    Langcraigs Drive
    PA2 8JP Paisley
    49
    Renfrewshire
    United Kingdom
    Scottish134480910001
    MINNERY, David John
    2 Inglestone Avenue
    Woodfarm
    G46 7ES Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    2 Inglestone Avenue
    Woodfarm
    G46 7ES Glasgow
    Lanarkshire
    British108814490001
    ARTHUR, Linda Ann
    Corrour Road
    Newlands
    G43 2DT Glasgow
    4
    Scotland
    Amministratore
    Corrour Road
    Newlands
    G43 2DT Glasgow
    4
    Scotland
    ScotlandBritish135510720001
    BENNETT, Ann
    98 Aurs Road
    G78 2NY Barrhead
    East Renfrewshire
    Amministratore
    98 Aurs Road
    G78 2NY Barrhead
    East Renfrewshire
    British114704940001
    BROWN, Mary Temple
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    Amministratore
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    ScotlandScottish34312250001
    BRYAN, Pauline Rita Carmela Catherine
    45 Greenhill Crescent
    PA3 3BY Linwood
    Renfrewshire
    Scotland
    Amministratore
    45 Greenhill Crescent
    PA3 3BY Linwood
    Renfrewshire
    Scotland
    British62132180001
    CARSWELL, Laura
    Kirkton Farm
    Neilston
    G78 3HN Glasgow
    Amministratore
    Kirkton Farm
    Neilston
    G78 3HN Glasgow
    ScotlandBritish111734220001
    CASTRO, Janet
    22 Golf Road
    Clarkston
    G76 7PY Glasgow
    East Renfrewshire
    Amministratore
    22 Golf Road
    Clarkston
    G76 7PY Glasgow
    East Renfrewshire
    United KingdomBritish170148500001
    DRENNAN, Olivia Marabel
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    Amministratore
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    ScotlandScottish161182600001
    DUNCAN, Catherine
    12 Graham Street
    Barrhead
    G78 1ET Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    12 Graham Street
    Barrhead
    G78 1ET Glasgow
    Lanarkshire
    British99342700001
    FINNIE, Jessie
    93 Main Street
    Thornliebank
    G46 7RY Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    93 Main Street
    Thornliebank
    G46 7RY Glasgow
    Lanarkshire
    British71773990001
    GILLAN, Margaret Irene
    25 Dougray Place
    Barrhead
    G78 2RP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    25 Dougray Place
    Barrhead
    G78 2RP Glasgow
    Lanarkshire
    British99342730001
    GREENHILL, Kenneth Goodman
    11 Cadzow Avenue
    Giffnock
    G46 6RD Glasgow
    Amministratore
    11 Cadzow Avenue
    Giffnock
    G46 6RD Glasgow
    United KingdomBritish78887230003
    HEALY, Steven William Madden
    Hillside Road
    G78 3ER Neilston
    24
    East Renfrewshire
    Scotland
    Amministratore
    Hillside Road
    G78 3ER Neilston
    24
    East Renfrewshire
    Scotland
    ScotlandBritish139886610001
    HERON, Jacqueline Kennedy
    21 Armour Square
    PA5 8AD Johnstone
    Renfrewshire
    Amministratore
    21 Armour Square
    PA5 8AD Johnstone
    Renfrewshire
    ScotlandBritish125193820002
    HUNTER, Walter
    248f Main Street
    Barrhead
    G78 1SR Glasgow
    Amministratore
    248f Main Street
    Barrhead
    G78 1SR Glasgow
    British59121170001
    KITCHENER, Muriel Gertrude
    Flat 3a, 19 Milverton Road
    Giffnock
    G46 7JN Glasgow
    Amministratore
    Flat 3a, 19 Milverton Road
    Giffnock
    G46 7JN Glasgow
    British59121160001
    MCCORMACK, Angela Janet
    Langcraigs Drive
    PA2 8JP Paisley
    49
    Renfrewshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Langcraigs Drive
    PA2 8JP Paisley
    49
    Renfrewshire
    United Kingdom
    ScotlandScottish134480910001
    MCGEADY, Joseph Brian
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    Amministratore
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    ScotlandBritish153160310001
    MCGILLIVRAY, Iain Archibald
    20 Berryhill Drive
    Giffnock
    G46 7AA Glasgow
    East Renfrewshire
    Scotland
    Amministratore
    20 Berryhill Drive
    Giffnock
    G46 7AA Glasgow
    East Renfrewshire
    Scotland
    British62132000001
    MCGUIRE, Catherine
    39 Rufflees Avenue
    Barrhead
    G78 1BB Glasgow
    Amministratore
    39 Rufflees Avenue
    Barrhead
    G78 1BB Glasgow
    British59121140001
    MCKEMMIE, Ross Christison
    10 Merrylee Crescent
    Giffnock
    G46 6AP Glasgow
    Amministratore
    10 Merrylee Crescent
    Giffnock
    G46 6AP Glasgow
    ScotlandBritish3217560001
    MCKEMMIE, Ross Christison
    10 Merrylee Crescent
    Giffnock
    G46 6AP Glasgow
    Amministratore
    10 Merrylee Crescent
    Giffnock
    G46 6AP Glasgow
    ScotlandBritish3217560001
    MCQUADE, Brenda
    45 Levern Crescent
    G78 2AD Barrhead
    Renfrewshire
    Amministratore
    45 Levern Crescent
    G78 2AD Barrhead
    Renfrewshire
    British114705080001
    MOORE, Ann Pagan
    5 The Loaning
    G46 6SE Glasgow
    Strathclyde
    Amministratore
    5 The Loaning
    G46 6SE Glasgow
    Strathclyde
    ScotlandBritish82633870001
    MOORE, Hugh Alexander Mathison
    11 Carleton Drive
    Giffnock
    G46 6AJ East Renfrewshire
    Amministratore
    11 Carleton Drive
    Giffnock
    G46 6AJ East Renfrewshire
    British82205670001
    REID, Jacqueline Taylor
    Broomvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5NW Glasgow
    21
    Scotland
    Amministratore
    Broomvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5NW Glasgow
    21
    Scotland
    ScotlandBritish186436920002
    REID, Jaqueline
    21 Broomvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5NW Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    21 Broomvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5NW Glasgow
    Lanarkshire
    British123618140001
    ROBERTSON, Lisa-Marie
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    Amministratore
    56 Kelburn Street
    G78 1LR Barrhead
    Undercover
    East Renfrewshire
    ScotlandScottish153167300001

    VOLUNTARY ACTION EAST RENFREWSHIRE ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 10 mar 2006
    Consegnato il 18 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest in lease over unit 8 westbourne centre, kelburn street, barrhead and area of ground outside REN118897 REN118898.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Ministers
    Transazioni
    • 18 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 28 ott 2005
    Consegnato il 16 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The lease of the subjects forming unit 8 of the westbourne centre, kelburn street, barrhead being the subjects on the ground floor and lower ground floor (title numbers REN112124 and REN3350) and the lease of that area of ground outside unit 8, westbourne centre, kelburn street, barrhead (title number REN3350).
    Persone aventi diritto
    • The National Lottery Charities Board
    Transazioni
    • 16 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0