RENAISSANCE CARE (SCOTLAND) LIMITED

RENAISSANCE CARE (SCOTLAND) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRENAISSANCE CARE (SCOTLAND) LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC190022
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di RENAISSANCE CARE (SCOTLAND) LIMITED?

    • Strutture residenziali di assistenza per anziani e disabili (87300) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova RENAISSANCE CARE (SCOTLAND) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Archibald Hope House
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RENAISSANCE CARE (SCOTLAND) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FORTH CARE LIMITED18 feb 200518 feb 2005
    LEVENHALL CARE LIMITED06 ott 199806 ott 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di RENAISSANCE CARE (SCOTLAND) LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 nov 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 ago 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per RENAISSANCE CARE (SCOTLAND) LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al06 ott 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma20 ott 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al06 ott 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per RENAISSANCE CARE (SCOTLAND) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Miss Kirstene Feenan come amministratore in data 17 giu 2025

    2 pagineAP01

    Bilancio consolidato redatto al 30 nov 2024

    40 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Anya Elizabeth Neilson il 04 apr 2025

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Yvonne Mackenzie il 25 nov 2022

    2 pagineCH01

    Bilancio consolidato redatto al 30 nov 2023

    37 pagineAA

    Seconda presentazione della Dichiarazione di conformità datata 16 ott 2023

    3 pagineRP04CS01

    Memorandum e Statuto

    29 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzioni

    New share class and authorised to take steps to issue and allot 21/09/2023
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 21 set 2023

    • Capitale: GBP 52,632
    3 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2023 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    Note
    DataNota
    19 feb 2024Second Filing The information on the form CS01 has been replaced by a second filing on 19/02/2024

    Bilancio consolidato redatto al 30 nov 2022

    36 pagineAA

    Nomina di Mr Liam Michael Bain come amministratore in data 01 ott 2022

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Declan Walsh come amministratore in data 24 giu 2022

    1 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 30 nov 2021

    39 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere SC1900220012 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1900220013 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1900220014 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC1900220016 in pieno

    1 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Suite 2, Ground Floor, Stuart House Eskmills Park Station Road Musselburgh Midlothian EH21 7PB a Archibald Hope House Station Road Musselburgh EH21 7PQ in data 03 mar 2022

    1 pagineAD01

    Iscrizione dell'ipoteca SC1900220017, creata il 19 gen 2022

    38 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Michael Hugh Reid come amministratore in data 01 set 2021

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di RENAISSANCE CARE (SCOTLAND) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAIN, Liam Michael
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    Amministratore
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    ScotlandBritish269084310001
    BARNETT, Louise
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    Amministratore
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    ScotlandBritish205994050001
    FEENAN, Kirstene
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    Amministratore
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    ScotlandBritish337036900001
    HARPER, Robert David
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    Amministratore
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    ScotlandBritish198843180001
    KILGOUR, Robert Dow
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    Amministratore
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    EnglandBritish252153670001
    NEILSON, Anya Elizabeth
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    Amministratore
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    ScotlandBritish152209190003
    REID, Michael Hugh
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    Amministratore
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    ScotlandScottish196323400001
    RICHARDSON, Yvonne
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    Amministratore
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    ScotlandBritish276948260002
    GORDON, Margaret Anne
    75 St Stephen Street
    EH3 5AG Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    75 St Stephen Street
    EH3 5AG Edinburgh
    Midlothian
    British1245560001
    WRIGHT, Alan
    23 Greenock Road
    KA30 8PH Largs
    Ayrshire
    Segretario
    23 Greenock Road
    KA30 8PH Largs
    Ayrshire
    British320580005
    CCW SECRETARIES LIMITED
    Crescent House
    Carnegie Campus
    KY11 8GR Dunfermline
    -
    Fife
    Great Britain
    Segretario
    Crescent House
    Carnegie Campus
    KY11 8GR Dunfermline
    -
    Fife
    Great Britain
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC182936
    63577400019
    FIRST SCOTTISH SECRETARIES LIMITED
    St Davids House
    St Davids Drive
    KY11 9NB Dalgety Bay
    Segretario nominato
    St Davids House
    St Davids Drive
    KY11 9NB Dalgety Bay
    900008570001
    DOCHERTY, Claire
    Eskmills Park
    Station Road
    EH21 7PB Musselburgh
    Suite 2, Ground Floor, Stuart House
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    Eskmills Park
    Station Road
    EH21 7PB Musselburgh
    Suite 2, Ground Floor, Stuart House
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish169011360001
    GORDON, Margaret Anne
    Duddingston Road
    EH15 1SG Edinburgh
    58
    United Kingdom
    Amministratore
    Duddingston Road
    EH15 1SG Edinburgh
    58
    United Kingdom
    United KingdomBritish1245560002
    HENRY, Yvonne
    13 Glamis Gardens
    KY11 9TD Dalgety Bay
    Fife
    Amministratore
    13 Glamis Gardens
    KY11 9TD Dalgety Bay
    Fife
    British102778010001
    HENRY, Yvonne
    13 Glamis Gardens
    KY11 9TD Dalgety Bay
    Fife
    Amministratore
    13 Glamis Gardens
    KY11 9TD Dalgety Bay
    Fife
    British102778010001
    LIDDELL, Carol
    54 Durham Square
    EH15 1PP Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    54 Durham Square
    EH15 1PP Edinburgh
    Midlothian
    British882980001
    LIDDELL, Stephen Charles
    54 Durham Square
    EH15 1PP Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    54 Durham Square
    EH15 1PP Edinburgh
    Midlothian
    British882970001
    MCCULLOCH-BROWN, Jane Catherine
    Nether Kidston Farmhouse
    EH45 8PJ Peebles
    Peeblesshire
    Amministratore
    Nether Kidston Farmhouse
    EH45 8PJ Peebles
    Peeblesshire
    British111962540001
    MCLEISH, William David
    Eskmills Park
    Station Road
    EH21 7PB Musselburgh
    Suite 2, Ground Floor, Stuart House
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    Eskmills Park
    Station Road
    EH21 7PB Musselburgh
    Suite 2, Ground Floor, Stuart House
    Midlothian
    Scotland
    United KingdomBritish168970640001
    MURIE, Elaine
    Stuart House
    Station Road
    EH21 7PB Eskmills
    Suite 5 1st Floor
    Musselburgh
    Amministratore
    Stuart House
    Station Road
    EH21 7PB Eskmills
    Suite 5 1st Floor
    Musselburgh
    United KingdomBritish148834520001
    THORBURN, Robina Cockburn Trent Weir
    49 Stoneyhill Road
    EH21 6TW Musselburgh
    Midlothian
    Amministratore
    49 Stoneyhill Road
    EH21 6TW Musselburgh
    Midlothian
    British64637960001
    THORNBURN, Robina Trent Weir
    49 Stoneyhill Road
    EH21 6TW Musselburgh
    Midlothian
    Amministratore
    49 Stoneyhill Road
    EH21 6TW Musselburgh
    Midlothian
    British102778090001
    WALSH, Declan
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    Amministratore
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    ScotlandIrish286979380001
    WRIGHT, Alan
    23 Greenock Road
    KA30 8PH Largs
    Ayrshire
    Amministratore
    23 Greenock Road
    KA30 8PH Largs
    Ayrshire
    United KingdomBritish320580005
    WRIGHT, Alan
    23 Greenock Road
    KA30 8PH Largs
    Ayrshire
    Amministratore
    23 Greenock Road
    KA30 8PH Largs
    Ayrshire
    United KingdomBritish320580005
    FIRST SCOTTISH INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
    St Davids House
    St Davids Drive
    KY11 9NB Dalgety Bay
    Amministratore delegato nominato
    St Davids House
    St Davids Drive
    KY11 9NB Dalgety Bay
    900008560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RENAISSANCE CARE (SCOTLAND) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Robert Dow Kilgour
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    06 apr 2016
    Station Road
    EH21 7PQ Musselburgh
    Archibald Hope House
    Scotland
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0