MORRISON RAIL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MORRISON RAIL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC197529 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MORRISON RAIL LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MORRISON RAIL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Ocean Point 1st Floor, 94 Ocean Drive EH6 6JH Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MORRISON RAIL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MORRISON (NEWCO. 2) LIMITED | 12 mag 2000 | 12 mag 2000 |
| MORRISON OUTLETS LIMITED | 19 apr 2000 | 19 apr 2000 |
| MORRISON (NEWCO. 2) LIMITED | 01 dic 1999 | 01 dic 1999 |
| WELLSTRIPE LIMITED | 24 giu 1999 | 24 giu 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MORRISON RAIL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per MORRISON RAIL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Morco (3) Limited come persona con controllo significativo il 26 set 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jonathan David Forster il 03 ott 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Morco (3) Limited come persona con controllo significativo il 18 gen 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ocean Point 1st Floor, Ocean 94 Ocean Drive Edinburgh Eh6 6 Jh United Kingdom a Ocean Point 1st Floor, 94 Ocean Drive Edinburgh EH6 6JH in data 18 gen 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Morco (3) Limited come persona con controllo significativo il 18 gen 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 47 Melville Street Edinburgh EH3 7HL a Ocean Point 1st Floor, Ocean 94 Ocean Drive Edinburgh Eh6 6 Jh in data 18 gen 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Claire Tytherleigh Russell come amministratore in data 28 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Elizabeth Ann Horlock Clarke come amministratore in data 28 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Claire Tytherleigh Russell come amministratore in data 30 nov 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Elizabeth Ann Horlock Clarke come amministratore in data 01 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Geoffrey Arthur George Shepheard come segretario in data 31 mar 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Elizabeth Ann Horlock Clarke come segretario in data 01 apr 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MORRISON RAIL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Elizabeth Ann Horlock | Segretario | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6YJ Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | 198551350001 | |||||||
| FORSTER, Jonathan David | Amministratore | 1st Floor, 94 Ocean Drive EH6 6JH Edinburgh Ocean Point United Kingdom | United Kingdom | British | 101812460002 | |||||
| RUSSELL, Claire Tytherleigh | Amministratore | 1st Floor, 94 Ocean Drive EH6 6JH Edinburgh Ocean Point United Kingdom | England | British | 105433380001 | |||||
| FOX, Jacqueline Elizabeth | Segretario | Little Dormers 3 Wicken Road CB11 3QD Newport Essex | British | 35460890004 | ||||||
| GILLEN, Seamus Joseph | Segretario | 20 Mountway EN6 1EP Potters Bar Hertfordshire | British | 66174560001 | ||||||
| HOWELL, Keith Martin | Segretario | Lynehurst Carlops Road EH46 7DS West Linton Peeblesshire | British | 1499960006 | ||||||
| MORRISON, John | Segretario | Willis Mar,13 Glen Brae FK1 5LH Falkirk | British | 54477430001 | ||||||
| SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Segretario | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||
| TURNER, David Charles | Segretario | 13 Thorndales St Johns Avenue CM14 5DE Brentwood Essex | Other | 84007940001 | ||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Segretario nominato | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| ANDERSON, Mark Stephen | Amministratore | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | England | British | 122463830003 | |||||
| BROWNE, Dominic Michael | Amministratore | 3 Leam Road CV31 3PA Leamington Spa Warwickshire | British | 45360530001 | ||||||
| CLARKE, Elizabeth Ann Horlock | Amministratore | Melville Street EH3 7HL Edinburgh 47 | United Kingdom | British | 203580340001 | |||||
| FIRTH, Patrick | Amministratore | The Cottage High Street PE28 0AB Ellington Huntingdon Cambs | British | 85034900001 | ||||||
| GILLESPIE, Kenneth | Amministratore | 15 Craigs Bank EH12 8HD Edinburgh | England | British | 77321980001 | |||||
| GREEN, Robert David | Amministratore | 1a Burnside Road White Craigs G46 6TT Glasgow | British | 76720550002 | ||||||
| HAMPSON, Michael David | Amministratore | Anglian House Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Cambs | British | 105084640001 | ||||||
| HILLS, Mark Robert | Amministratore | Linton Muir EH46 7AS West Linton Peeblesshire | British | 68584720001 | ||||||
| HOWELL, Keith Martin | Amministratore | Lynehurst Carlops Road EH46 7DS West Linton Peeblesshire | British | 1499960006 | ||||||
| JEFFS, David John | Amministratore | 17 Old Mill Lane Clifford LS23 6LE Wetherby West Yorkshire | England | British | 3812460001 | |||||
| LE LORRAIN, Michael Robert | Amministratore | Orchard House 3 Lea Brooks Close PE28 2RA Warboys Cambridgeshire | England | British | 93716830003 | |||||
| MARTIN, Joseph Michael | Amministratore | 8 Mill View School Lane Eaton Socon PE19 3HJ St Neots Cambridgeshire | British | 1092550002 | ||||||
| MATHESON, Charles | Amministratore | 61 Albert Drive SW19 6LB London | United Kingdom | British | 99045990001 | |||||
| MCBRIERTY, Stephen John | Amministratore | 14 Auchingane EH10 7HX Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 48390780001 | |||||
| MCFADZEAN, John Findlay | Amministratore | Wester Nether Urquhart House Strathmiglo KY14 7RR Cupar Fife | Scotland | British | 50511480001 | |||||
| MORRISON, John | Amministratore | Willis Mar 13 Glen Brae FK1 5LT Falkirk Central Scotland | British | 1500260013 | ||||||
| O'DELL, Robert James | Amministratore | 12 Wensley Grove HG2 8AH Harrogate North Yorkshire | British | 6337720001 | ||||||
| O'REILLY, Brendon | Amministratore | 92 Binniehill Road Balloch Cumbernauld G68 9JJ Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 70037900002 | |||||
| RUSSELL, Claire Tytherleigh | Amministratore | Melville Street EH3 7HL Edinburgh 47 | England | British | 105433380001 | |||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Amministratore | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | England | British | 135181230001 | |||||
| WALSH, Stephen | Amministratore | 589 London Road Davenham CW9 8LN Northwich Cheshire | England | British | 60529360002 | |||||
| WARRACK, Anne Victoria Mary | Amministratore | The White Cottage 153 Bridge Street, Whddon SG8 5SP Royston Herts | United Kingdom | British | 123157220001 | |||||
| WINWARD, Martin Johnson | Amministratore | Entwhistle House Entwhistle BL7 0LR Bolton Lancashire | England | British | 17166820001 | |||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Amministratore delegato nominato | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MORRISON RAIL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave Holdings Limited | 06 apr 2016 | 1st Floor, 94 Ocean Drive EH6 6JH Edinburgh Ocean Point United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0