KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED

KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC200611
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED?

    • (7012) /

    Dove si trova KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    69 St Vincent Street
    Glasgow
    G2 5TF
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOMACK (NO. 62) LIMITED07 ott 199907 ott 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    4 pagineMG05s

    legacy

    3 pagineMG04s

    legacy

    3 pagineMG04s

    legacy

    3 pagineMG04s

    legacy

    3 pagineMG04s

    legacy

    3 pagineMG04s

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    1 pagine652a

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    18 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    2 pagine122

    legacy

    2 pagine419a(Scot)

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    16 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    16 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARK, Graham Iain
    412 Castle Gait
    PA1 2HE Paisley
    Segretario
    412 Castle Gait
    PA1 2HE Paisley
    British94940840001
    CLARK, Graham Iain
    412 Castle Gait
    PA1 2HE Paisley
    Amministratore
    412 Castle Gait
    PA1 2HE Paisley
    ScotlandBritish94940840001
    GLEN, Maurice
    17 Juniper Avenue
    PA11 3NS Bridge Of Weir
    Amministratore
    17 Juniper Avenue
    PA11 3NS Bridge Of Weir
    ScotlandBritish1408430004
    CUSACK, Suzanne
    57 Tiree, St Leonards
    G74 2DR East Kilbride
    Segretario
    57 Tiree, St Leonards
    G74 2DR East Kilbride
    British76515980001
    GLEN, Susan Munro Inglis
    54 Dunellan Road
    Milngavie
    G62 7RE Glasgow
    Strathclyde
    Segretario
    54 Dunellan Road
    Milngavie
    G62 7RE Glasgow
    Strathclyde
    British37382080001
    DOMICILE EXECUTORS TRUSTEES & NOMINEES LIMITED
    109 Douglas Street
    G2 4HB Glasgow
    Segretario
    109 Douglas Street
    G2 4HB Glasgow
    269420001
    IRVINE, Alasdair Iain
    13 Bent Road
    ML3 6QB Hamilton
    South Lanarkshire
    Amministratore
    13 Bent Road
    ML3 6QB Hamilton
    South Lanarkshire
    United KingdomBritish66640060002
    KEIR, Gordon John Millar
    42 Kilbarchan Road
    PA11 3EZ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Amministratore
    42 Kilbarchan Road
    PA11 3EZ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    United KingdomBritish80335540002
    MCLEW, Kenneth David Brownlie
    15 Hamilton Avenue
    Pollokshields
    G41 4JG Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    15 Hamilton Avenue
    Pollokshields
    G41 4JG Glasgow
    Lanarkshire
    British719600001
    MCNEILL, James Stuart
    13 Springkell Gardens
    Pollokshields
    G41 4BP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    13 Springkell Gardens
    Pollokshields
    G41 4BP Glasgow
    Lanarkshire
    British719610001

    KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 18 nov 2005
    Consegnato il 23 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The golden lion filling station, montrose road, arbroath ang 3019.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 gen 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    Legal charge
    Creato il 28 giu 2005
    Consegnato il 08 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the freehold property known as 8 station road, ashington, northumberland (title number ND45518).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 gen 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    Standard security
    Creato il 25 feb 2005
    Consegnato il 01 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    8-10 high street, ayr AYR27163.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 gen 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    Legal charge
    Creato il 05 ott 2004
    Consegnato il 18 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over 22 highgate, kendal cumbria CU153834.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 gen 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    Standard security
    Creato il 23 apr 2004
    Consegnato il 30 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    16 high street, alloa.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 05 gen 2004
    Consegnato il 15 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    62/66 high street, leven.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 22 set 2003
    Consegnato il 30 set 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    50 high street, johnstone--title number REN884.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 gen 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    Standard security
    Creato il 13 mar 2003
    Consegnato il 27 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    103 main street, coatbridge.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 18 dic 2002
    Consegnato il 24 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    52C high street, johnstone--title number REN18601.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 19 gen 2000
    Consegnato il 25 gen 2000
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 feb 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (MG05s)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0