MILLER DEVELOPMENTS REGENERATION LIMITED

MILLER DEVELOPMENTS REGENERATION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMILLER DEVELOPMENTS REGENERATION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC207809
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MILLER DEVELOPMENTS REGENERATION LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova MILLER DEVELOPMENTS REGENERATION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    201 West George Street
    C/O Miller Developments
    G2 2LW Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MILLER DEVELOPMENTS REGENERATION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALBA CAMPUS LIMITED25 set 200025 set 2000
    M M & S (2649) LIMITED06 giu 200006 giu 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di MILLER DEVELOPMENTS REGENERATION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per MILLER DEVELOPMENTS REGENERATION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2021

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 gen 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Sutherland il 16 ott 2020

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    12 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow G2 2LW Scotland a 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow Lanarkshire G2 2LW in data 05 feb 2020

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL a 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow G2 2LW in data 04 feb 2020

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Miller Developments Holdings Limited come persona con controllo significativo il 03 feb 2020

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    13 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Miller House 2 Lochside View Edinburgh Park Edinburgh EH12 9DH a 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL in data 25 gen 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 gen 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere SC2078090010 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 gen 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Euan James Edward Haggerty come amministratore in data 30 giu 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 gen 2016

    Stato del capitale al 18 gen 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Chi sono gli amministratori di MILLER DEVELOPMENTS REGENERATION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MILLOY, David Thomas
    West George Street
    C/O Miller Developments
    G2 2LW Glasgow
    201
    Lanarkshire
    Scotland
    Amministratore
    West George Street
    C/O Miller Developments
    G2 2LW Glasgow
    201
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish76474600001
    SUTHERLAND, Andrew
    West George Street
    C/O Miller Developments
    G2 2LW Glasgow
    201
    Lanarkshire
    Scotland
    Amministratore
    West George Street
    C/O Miller Developments
    G2 2LW Glasgow
    201
    Lanarkshire
    Scotland
    CanadaBritish66368290041
    SMYTH, Pamela June
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Segretario
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    British65057960002
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Segretario nominato
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    BARCLAY, Suzanne Victoria
    5 Gogarloch Haugh
    EH12 9JG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 Gogarloch Haugh
    EH12 9JG Edinburgh
    Midlothian
    British103013140001
    BORLAND, Donald William
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Amministratore
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    United KingdomBritish66010670002
    CRICHTON, David
    St Peter's Hall
    34 Main Street
    EH31 2AA Gullane
    East Lothian
    Amministratore
    St Peter's Hall
    34 Main Street
    EH31 2AA Gullane
    East Lothian
    ScotlandBritish102111000001
    DEANS, Thomas Malcolm
    69 Hillview Road
    EH12 8QH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    69 Hillview Road
    EH12 8QH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish848410001
    DICKSON, Pamela Simone
    38 Belmont Gardens
    EH12 6JD Edinburgh
    Amministratore
    38 Belmont Gardens
    EH12 6JD Edinburgh
    United KingdomScottish91810830001
    FRANCIS, Neil David
    13 Broden Road
    Jordanhill
    G13 1RB Glasgow
    Amministratore
    13 Broden Road
    Jordanhill
    G13 1RB Glasgow
    ScotlandBritish90852100001
    GALLAGHER, Stephen John Patrick
    7 Peiter Place
    West Craigs
    G72 0RG High Blantyre
    Lanarkshire
    Amministratore
    7 Peiter Place
    West Craigs
    G72 0RG High Blantyre
    Lanarkshire
    British110620940001
    HAGGERTY, Euan James Edward
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Amministratore
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    ScotlandBritish162679260001
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    Amministratore
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish113081830001
    HODSDEN, Richard David
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Amministratore
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    EnglandBritish183337930001
    LEWIS, Paul Dominic
    144 Craigleith Road
    EH4 2EQ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    144 Craigleith Road
    EH4 2EQ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish80689030001
    MCFARLANE, James Mclean Henderson
    13 St. Andrews Street
    EH39 4NU North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    13 St. Andrews Street
    EH39 4NU North Berwick
    East Lothian
    British93222200002
    MCGARVA, Steven
    4 Clifford Court, 271 Nithsdale Road
    G41 5LS Glasgow
    Strathclyde
    Amministratore
    4 Clifford Court, 271 Nithsdale Road
    G41 5LS Glasgow
    Strathclyde
    British72941560001
    MILLER, Philip Hartley
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Amministratore
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    ScotlandBritish28512070005
    MILLOY, David Thomas
    1 Thorn Avenue
    Thorntonhall
    G74 5AT Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    1 Thorn Avenue
    Thorntonhall
    G74 5AT Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish76474600001
    MOORE, Gillian Christine
    New Uberior House
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    New Uberior House
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    Midlothian
    British81161980001
    RICHARDS, John Steel
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Amministratore
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    United KingdomBritish1318380002
    TAYLOR, David
    Primrose Villa,19 Glenbrook
    Balerno
    EH14 7JE Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    Primrose Villa,19 Glenbrook
    Balerno
    EH14 7JE Edinburgh
    Midlothian
    British73070810001
    WOOD, Marlene
    15 Ormidale Terrace
    EH12 6DY Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    15 Ormidale Terrace
    EH12 6DY Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish31152030002
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Amministratore
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    64555080001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Amministratore
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    64555070001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MILLER DEVELOPMENTS REGENERATION LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    St. Paul's Churchyard
    EC4M 8AL London
    Condor House
    England
    06 apr 2016
    St. Paul's Churchyard
    EC4M 8AL London
    Condor House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00849553
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MILLER DEVELOPMENTS REGENERATION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 ott 2015
    Consegnato il 14 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 14 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 03 ott 2012
    Consegnato il 12 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Property lying to the east of east avenue linwood paisley REN107499.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 06 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 07 mar 2012
    Consegnato il 15 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Newshot island, erskine REN127163.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 06 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 07 mar 2012
    Consegnato il 15 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Phoenix development site, linwood road, paisley ren 55134 & land on north and north east side of phoenix park REN97541.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 06 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 feb 2012
    Consegnato il 08 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 06 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Bond & floating charge
    Creato il 29 feb 2012
    Consegnato il 08 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 06 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 30 mar 2011
    Consegnato il 31 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of the minute of agreement
    Brevi particolari
    Newshot island in the county of renfrew REN127163.
    Persone aventi diritto
    • David Archibald James Methuen Campbell & Others
    Transazioni
    • 31 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 24 lug 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 10 apr 2002
    Consegnato il 22 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The MOB1 building, alba campus, livingston.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 19 ott 2001
    Consegnato il 26 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All and whole the subjects and others situated on the south side of livingsotn to stoneyburn road known as and forming alba campus, livingston.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Bond & floating charge
    Creato il 12 lug 2001
    Consegnato il 17 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0