WILBURN HOMES LIMITED

WILBURN HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWILBURN HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC214854
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WILBURN HOMES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova WILBURN HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    19 Rutland Square
    Edinburgh
    EH1 2BB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WILBURN HOMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    M M & S (2731) LIMITED17 gen 200117 gen 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di WILBURN HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WILBURN HOMES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WILBURN HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Soddisfazione dell'onere 25 in pieno

    4 pagineMR04

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 22 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2014

    Stato del capitale al 06 gen 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 22 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    4 pagineMG03s

    legacy

    4 pagineMG03s

    legacy

    7 pagineMG01s

    legacy

    7 pagineMG01s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    Chi sono gli amministratori di WILBURN HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURNS, Keith
    Flat 11, 3 Roseburn Maltings
    EH12 5LY Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    Flat 11, 3 Roseburn Maltings
    EH12 5LY Edinburgh
    Midlothian
    British107778410001
    BURNS, Keith
    Flat 11, 3 Roseburn Maltings
    EH12 5LY Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    Flat 11, 3 Roseburn Maltings
    EH12 5LY Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector107778410001
    BURNS, Patrick
    5 Succoth Gardens
    EH12 6BR Edinburgh
    Amministratore
    5 Succoth Gardens
    EH12 6BR Edinburgh
    ScotlandBritishChartered Surveyor53240380001
    KELLY, Peter
    Sandhill Cottage
    Southwood Road
    KA10 7EL Troon
    Segretario
    Sandhill Cottage
    Southwood Road
    KA10 7EL Troon
    BritishAccountant8888290009
    MURRAY, Sheena Pearl
    47 Baberton Mains Road
    EH4 3EZ Edinburgh
    Segretario
    47 Baberton Mains Road
    EH4 3EZ Edinburgh
    British60927150001
    STEWART, Julie Anne
    151d North High Street
    EH21 6AN Musselburgh
    Midlothian
    Segretario
    151d North High Street
    EH21 6AN Musselburgh
    Midlothian
    BritishCompany Secretary122803510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Segretario nominato
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    LOBB, Stuart Grigor
    22 St Ronans Terrace
    EH44 6RB Innerleithen
    Peeblesshire
    Amministratore
    22 St Ronans Terrace
    EH44 6RB Innerleithen
    Peeblesshire
    ScotlandBritishDirector120349500001
    MARTIN, Darren Richard
    6 Henderson Terrace
    EH11 2JZ Edinburgh
    Amministratore
    6 Henderson Terrace
    EH11 2JZ Edinburgh
    United KingdomBritishDirector103379290002
    MCKAY, Harry
    7 Dalfaber Park
    PH22 1QF Aviemore
    Amministratore
    7 Dalfaber Park
    PH22 1QF Aviemore
    ScotlandBritishBuilder86300650001
    SMITH, Norman Alan
    Auchengrange Steading
    Balltrees Road
    PA12 4JS Lochwinnoch
    Amministratore
    Auchengrange Steading
    Balltrees Road
    PA12 4JS Lochwinnoch
    ScotlandBritishSolicitor156114890001
    WILSON, John Dickson
    Rokeby 33 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4EF Stirling
    Stirlingshire
    Amministratore
    Rokeby 33 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4EF Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritishDirector146410001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    WILBURN HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 05 set 2012
    Consegnato il 12 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    31-35 fort street ayr AYR68873 and 9,11,and 13 citadel place ayre AYR50871.
    Persone aventi diritto
    • Longbow Investment No.2 S.A.R.L
    Transazioni
    • 12 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 10 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 31 ago 2012
    Consegnato il 07 set 2012
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Longbow Investment No.2 S.A.R.L.
    Transazioni
    • 07 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Floating charge
    Creato il 08 ott 2009
    Consegnato il 16 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 12 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Standard security
    Creato il 13 mag 2009
    Consegnato il 15 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Milton house newburgh road abernethy PTH31471.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 15 nov 2007
    Consegnato il 23 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of gtround at abernethy bounded on south by public road leading from abernethy to bewburgh , district and county of perth.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 15 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    That area or piece of ground lying on the corner of victoria street and albert crescent, newpot-on-tay, fife extending to 0.11 hectares (0.27 acres) or thereby.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 14 set 2007
    Consegnato il 25 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    11-13 east road, cupar FFE18845.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 set 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 25 lug 2007
    Consegnato il 30 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects on south west side of west port, cupar, fife FFE78169.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 09 lug 2007
    Consegnato il 12 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at nicol street, kirkcaldy in the county of fife extending to 0.561 acres or thereby.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 09 lug 2007
    Consegnato il 12 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at citadel place and fort street, ayr AYR50817 AYR68873.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 15 giu 2007
    Consegnato il 25 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground at milton house, abernethy, county of perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 30 apr 2007
    Consegnato il 08 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of land FFE36782.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 14 mar 2007
    Consegnato il 22 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    That area of ground at 99 church street in the district and county of inverness - see paper apart to form 410 for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 08 mar 2007
    Consegnato il 16 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Those subjects known as woodyard cottage at tulloch street, dingwall extending to one hundred and ninety three decimal or one thousandth parts of an acre or thereby lying in the former burgh and parish of dingwall.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 26 gen 2007
    Consegnato il 14 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Mart office & sales room at tulloch street, dingwall.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 19 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground at culcharry, near cawdor, nairn NRN1159.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 02 nov 2006
    Consegnato il 13 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1.469 ha of ground lying to northwest of south road, cupar, fife.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 19 ott 2006
    Consegnato il 01 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    That area of ground located at number 10 kinchurdy road, boat of garten in the parish of duthill and rothiemurchus and county of inverness extending to 0.21 hectares or thereby.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 09 mag 2006
    Consegnato il 16 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The flatted ground and first floor dwellinghouse at 72 old town, peebles being part of the tenement 68, 70 and 72 old town pbl 849.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 25 apr 2006
    Consegnato il 15 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The subjects described in the paper apart being the property known as 64-72 old town, peebles.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 24 apr 2006
    Consegnato il 04 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The subjects situated at balnagowan, nethybridge inv 13375.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 24 apr 2006
    Consegnato il 28 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The subjects at largo road, st andrews ffe 48172.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 10 apr 2006
    Consegnato il 21 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The smiddy, market road, hgarntown on spey MOR2053.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 18 dic 2003
    Consegnato il 22 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond
    Brevi particolari
    The property known as site 6, dalfaber industrial estate, aviemore (title number IVN2308).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Floating charge
    Creato il 13 mag 2002
    Consegnato il 22 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0