SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED

SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOLSTAD CABLE (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC217939
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FOODSHARE LIMITED09 apr 200109 apr 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    23 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 apr 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    23 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca SC2179390011, creata il 12 ott 2020

    24 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca SC2179390012, creata il 12 ott 2020

    36 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca SC2179390013, creata il 12 ott 2020

    44 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca SC2179390014, creata il 12 ott 2020

    69 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca SC2179390010, creata il 12 ott 2020

    21 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca SC2179390009, creata il 12 ott 2020

    20 pagineMR01

    Memorandum e Statuto

    14 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 apr 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Roger Wilman il 08 apr 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Roger Wilman il 08 apr 2020

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Ledingham Chalmers Llp come segretario in data 08 nov 2019

    1 pagineTM02

    Nomina di Lc Secretaries Limited come segretario in data 08 nov 2019

    2 pagineAP04

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    24 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 apr 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    24 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LC SECRETARIES LIMITED
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Segretario
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazioneSC299827
    112802860001
    DALE, Graham Alexander
    Norfolk Road
    AB10 6JR Aberdeen
    33
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    Norfolk Road
    AB10 6JR Aberdeen
    33
    Aberdeenshire
    Scotland
    United KingdomBritishDirector139488940002
    WILMAN, Roger
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Amministratore
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector49072100011
    NEWBERRY, Clare
    28 Saint Anns Villas
    W11 4RS London
    Segretario
    28 Saint Anns Villas
    W11 4RS London
    BritishSolicitor79423480001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Segretario
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    112938080001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Segretario
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Segretario nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    ALLAN, Keith Kellas Armstrong
    3 Riverside
    Blackhall
    AB31 6PS Banchory
    Kincardineshire
    Amministratore
    3 Riverside
    Blackhall
    AB31 6PS Banchory
    Kincardineshire
    ScotlandBritishCompany Director65176130001
    EIKESDAL, Harald Magne
    Strandgt 94
    Haugesund
    Norway
    Amministratore
    Strandgt 94
    Haugesund
    Norway
    NorwegianSolicitor78079660001
    KJAERSTAD, Helle
    9 Fox Hill Court
    Sussex Road
    RH16 4EB Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    9 Fox Hill Court
    Sussex Road
    RH16 4EB Haywards Heath
    West Sussex
    NorwegianTrainee Solicitor75991830001
    LÜHR OLSEN, Lars
    Gjerdegata
    6065 Ulsteinvik
    40
    Møre Og Romsdal
    Norway
    Amministratore
    Gjerdegata
    6065 Ulsteinvik
    40
    Møre Og Romsdal
    Norway
    NorwayNorwegianDeputy Managing Director, Ulstein Shipping As198225850001
    NEWBERRY, Clare
    28 Saint Anns Villas
    W11 4RS London
    Amministratore
    28 Saint Anns Villas
    W11 4RS London
    BritishSolicitor79423480001
    SOLSTAD, Ellen
    53 Albury Mansions
    AB11 6TJ Aberdeen
    Amministratore
    53 Albury Mansions
    AB11 6TJ Aberdeen
    NorwegianGeneral Manager76488220001
    STAKKESTAD, Sven
    Brakeveien 51
    Kopervik
    N4250
    Norway
    Amministratore
    Brakeveien 51
    Kopervik
    N4250
    Norway
    NorwayNorwegianCompany Director62575140001
    ULSTEIN, Gunvor
    6065 Ulsteinvik
    Onglasaetra 48
    Norway
    Amministratore
    6065 Ulsteinvik
    Onglasaetra 48
    Norway
    NorwegianCompany Director76280630002
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScotland
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc091332
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 ott 2020
    Consegnato il 15 ott 2020
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Dnb Bank Asa
    Transazioni
    • 15 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 ott 2020
    Consegnato il 15 ott 2020
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Dnb Bank Asa
    Transazioni
    • 15 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 ott 2020
    Consegnato il 15 ott 2020
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Dnb Bank Asa
    Transazioni
    • 15 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 ott 2020
    Consegnato il 15 ott 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Dnb Bank Asa
    Transazioni
    • 15 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 ott 2020
    Consegnato il 14 ott 2020
    In corso
    Breve descrizione
    All accounts referred to in recital (b) of the account security deed dated 12 october 2020.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Dnb Bank Asa
    Transazioni
    • 14 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 ott 2020
    Consegnato il 14 ott 2020
    In corso
    Breve descrizione
    M.V. normand clipper with imo number 9236200.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Dnb Bank Asa
    Transazioni
    • 14 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of general assignment
    Creato il 26 apr 2005
    Consegnato il 17 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All of the right, title and interest, present and future, actual or contingent of the company into, to and under: (a) the time charter guarantee dated 22 april 2005 made between clough limited and the company in relation to clough regional pty ltds obligations under (b) the time charterparty dated as of 22 april 2005 made between the company and clough regional pty LTD and all claims, rights and remedies of the company arising therefrom.
    Persone aventi diritto
    • Solstad Rederi As
    Transazioni
    • 17 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Deed of general assignment
    Creato il 12 mag 2004
    Consegnato il 19 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All right, title and interest of the company in, to and under the time charter.
    Persone aventi diritto
    • Solstad Rederi As
    Transazioni
    • 19 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Deed of general assignment (no.2)
    Creato il 15 apr 2003
    Consegnato il 24 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All of the right, title, benefit and interest, present and future, actual or contingent of the company in, to and under (a) the new tyco guarantee and (b) the assigned and assumed time charter and the time charter assignment and assumption agreement, and all claimes, rights and remedies of the company arising therefrom.
    Persone aventi diritto
    • Solstad Rederi As
    Transazioni
    • 24 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Deed of general assignment (no.2)
    Creato il 15 apr 2003
    Consegnato il 24 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All of the right, title, benefit and interest, present and future, actual or contingent of the company in, and to and under (a) the new tyco guarantee and (b) the assigned and assumed time charter and the time charter assignment and assumption agreement, and all claims, rights and remedies of the company.
    Persone aventi diritto
    • Solstad Rederi As
    Transazioni
    • 24 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Security deed of assignment
    Creato il 21 giu 2001
    Consegnato il 04 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sums and liabilities which are or may become payable or owing pursuant to the deposit agreement
    Brevi particolari
    All of the present and future rights, title, benefit and interest of the company in and to the deposit, the account and the deposit agreement.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 04 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Deed of general assignment
    Creato il 20 giu 2001
    Consegnato il 27 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All of the right, title and interest, present and future, actual or contingent of the company in, to and under (a) the tycom agreement, (b)the time charter, (c) the insurances and (d) any requisition compensation and al claims, rights and remedies of the company arising therefrom (including all damages and compensation payable for or in respect thereof) all the defined terms as defined in the assignment.
    Persone aventi diritto
    • Solstad Rederi As
    Transazioni
    • 27 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Security deed of assignment
    Creato il 05 giu 2001
    Consegnato il 20 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All of the present and future rights, title, benefit and interest of the company in and to the deposit, the account and the deposit agreement.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Deed of general assignment
    Creato il 30 mag 2001
    Consegnato il 04 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All of the right title and interest present and future actual or contingent of the company in to and under (a) the tycom gurantee (b)the time charter, (c) the insurances and (d) any requisition compensation and all claims rights and remedies of the company arising therefrom (including all damages and compensation payable for or in repsect thereof) all as the defined terms as defined in the assignment.
    Persone aventi diritto
    • Solstad Rederi As
    Transazioni
    • 04 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0