PACIFIC SHELF 1047 LIMITED

PACIFIC SHELF 1047 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPACIFIC SHELF 1047 LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione controllata
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC220011
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di PACIFIC SHELF 1047 LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova PACIFIC SHELF 1047 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PACIFIC SHELF 1047 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2007
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 ott 2008
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2006

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PACIFIC SHELF 1047 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al08 giu 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma22 giu 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PACIFIC SHELF 1047 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per PACIFIC SHELF 1047 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Iain James Blakeley come amministratore in data 03 nov 2023

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagine287

    Avviso di cessazione delle funzioni di ricevitore o gestore

    1 pagine3(Scot)

    Avviso del rapporto del ricevitore

    18 pagine3.5(Scot)

    Avviso di nomina del ricevitore da parte di un detentore di carica flottante

    2 pagine1(Scot)

    Avviso del rapporto del ricevitore

    18 pagine3.5(Scot)

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Avviso di nomina del ricevitore da parte di un detentore di carica flottante

    3 pagine1(Scot)

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    2 pagine419a(Scot)

    legacy

    2 pagine419a(Scot)

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    16 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    15 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    16 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di PACIFIC SHELF 1047 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHARON, Robert Danny
    Westerings
    City
    HP14 4AB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    Segretario
    Westerings
    City
    HP14 4AB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    British93514800001
    LANGRIDGE, Megan Joy
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    Segretario
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    British86459820005
    MCCLUSKEY, Brian
    5 Ayr Road
    KA9 1SX Prestwick
    Ayrshire
    Segretario
    5 Ayr Road
    KA9 1SX Prestwick
    Ayrshire
    British96335270001
    MCCRORY, David Andrew
    64 Terregles Avenue
    G41 4LX Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    64 Terregles Avenue
    G41 4LX Glasgow
    Lanarkshire
    British82928480001
    O'HARA, William Clive
    9 Eglinton Drive
    G46 7NQ Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    9 Eglinton Drive
    G46 7NQ Glasgow
    Lanarkshire
    British73042150001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Segretario nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BESLEY, Ian Philip Andrew
    52a Warrington Crescent
    W9 London
    Amministratore
    52a Warrington Crescent
    W9 London
    United KingdomBritish5677140001
    BLAKELEY, Iain James
    Shenley Hill
    WD7 7BD Radlett
    58
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Shenley Hill
    WD7 7BD Radlett
    58
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish135106330001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Danmure
    Western Avenue
    PH3 1IJ Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    Danmure
    Western Avenue
    PH3 1IJ Auchterarder
    Perthshire
    British75114520001
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    HANCOCK, Christopher
    Kynnersley
    Park Road Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Amministratore
    Kynnersley
    Park Road Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    EnglandBritish87069290001
    HUNTER, Thomas Blane, Sir
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    Amministratore
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    United KingdomBritish97904280003
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Amministratore
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritish23621230001
    MCCRORY, David Andrew
    64 Terregles Avenue
    G41 4LX Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    64 Terregles Avenue
    G41 4LX Glasgow
    Lanarkshire
    British82928480001
    MCMAHON, James Cairns
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    Amministratore
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    ScotlandBritish159708270001
    O'HARA, William Clive
    9 Eglinton Drive
    G46 7NQ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    9 Eglinton Drive
    G46 7NQ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish73042150001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    PACIFIC SHELF 1047 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 04 mag 2004
    Consegnato il 07 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    81 & 83 king street, 2 water lane & 36 sandbeg street, kilmarnock AYR38856.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 04 mag 2004
    Consegnato il 07 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    135/137 high street, perth PTH10462.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 21 apr 2004
    Consegnato il 08 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all estates or interests in the freehold and leasehold property; fixed and floating charges over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 mag 2004Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 01 giu 2004Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Legal charge
    Creato il 21 apr 2004
    Consegnato il 08 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over 41, 43 and 45 midland road, bedford (title number BD140132), 83 broadmead, bristol (title number AV97321) & 54 other properties - see mortgage document for full details - ; fixed and floating charges over assets.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 10 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    135-137 high street, perth.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited as Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 10 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 31 mar 2003
    Consegnato il 07 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    81-83 king street and 2 water lane, kilmarnock--title number ayr 38856.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 07 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    Deed of assignment
    Creato il 26 mar 2003
    Consegnato il 14 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All the rights, titles, benefits and interests of the company to the rents over the property known as angel shopping development, crewe (see mortgage document for full list of properties).
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 14 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 26 mar 2003
    Consegnato il 14 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charge over all moneys from time to time deposited with the trustee; floating charge over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 14 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 mag 2004Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 15 ago 2008Nomina di un amministratore o gestore (1 Scot)
    • 03 gen 2009Nomina di un amministratore o gestore (1 Scot)
    • Ha modifiche all'ordine:
      • Numero di pratica 1
      • Numero di pratica 2
    Assignation of rents
    Creato il 25 mar 2003
    Consegnato il 26 mar 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    135-137 high street, perth.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 26 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 25 mar 2003
    Consegnato il 26 mar 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    81-83 king street and 2 walter lane, kilmarnock.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 26 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 23 gen 2002
    Consegnato il 28 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the property (18 above bar, southampton), fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 12 set 2001
    Consegnato il 28 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    135 & 137 high street, perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 set 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 10 set 2001
    Consegnato il 28 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    81/83 king street and 2 water lane, kilmarnock.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 set 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    PACIFIC SHELF 1047 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Shay Bannon
    55 Baker Street
    London
    Ricevitore amministrativo
    55 Baker Street
    London
    Toby Scott Underwood
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Ricevitore amministrativo
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    James Bernard Stephen
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Ricevitore amministrativo
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Notescottish-insolvency-info
    2Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Shay Bannon
    55 Baker Street
    London
    Ricevitore amministrativo
    55 Baker Street
    London
    Toby Scott Underwood
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    Ricevitore amministrativo
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    James Bernard Stephen
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Ricevitore amministrativo
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0