CONTACT ADVANTAGE LIMITED
Panoramica
Nome della società | CONTACT ADVANTAGE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC223411 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CONTACT ADVANTAGE LIMITED?
- Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
Dove si trova CONTACT ADVANTAGE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 5 South Charlotte Street EH2 4AN Edinburgh Scotland |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di CONTACT ADVANTAGE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per CONTACT ADVANTAGE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 64a Cumberland Street Edinburgh EH3 6RE Scotland a 5 South Charlotte Street Edinburgh EH2 4AN in data 14 feb 2023 | 1 pagine | AD01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Sheri Anne Robinson il 10 gen 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr William Turpin Daughters Ii il 10 gen 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Norman Tommy Barras il 10 gen 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021 | 15 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Robert David Burnett come amministratore in data 01 nov 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mag 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Nomina di Christopher Brian Walsh come amministratore in data 26 gen 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Pamela Wright Lugo come segretario in data 01 feb 2022 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Jeffrey Scott Cherry come amministratore in data 26 gen 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Jeffrey Scott Cherry come segretario in data 01 feb 2022 | 1 pagine | TM02 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Pavillion 2 363 Helen Street Glasgow G51 3AD a 64a Cumberland Street Edinburgh EH3 6RE in data 12 gen 2022 | 1 pagine | AD01 | ||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020 | 16 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Notifica di Ucs Systems Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di Ucs Systems Limited come persona con controllo significativo il 12 mag 2021 | 1 pagine | PSC07 | ||
Nomina di Ms Sheri Anne Robinson come amministratore in data 22 dic 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr William Turpin Daughters Ii come amministratore in data 22 dic 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Jeffrey Scott Cherry come amministratore in data 22 dic 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Jeffrey Scott Cherry come segretario in data 22 dic 2020 | 2 pagine | AP03 | ||
Chi sono gli amministratori di CONTACT ADVANTAGE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGO, Pamela Wright | Segretario | c/o Andrew Partridge Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham 1200 England | 292291630001 | |||||||
BARRAS, Norman Tommy | Amministratore | Reynolds 1200 Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham C/O Andrew Partridge England | United States | American | Business Executive | 84053860001 | ||||
DAUGHTERS II, William Turpin | Amministratore | Reynolds 1200 Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham C/O Andrew Partridge England | United States | American | Executive | 277917100001 | ||||
ROBINSON, Sheri Anne | Amministratore | Reynolds 1200 Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham C/O Andrew Partridge England | United States | American | Executive | 277916710001 | ||||
WALSH, Christopher Brian | Amministratore | c/o Andrew Partridge Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham 1200 England | United States | American | Evp Sales | 292290250001 | ||||
BESWITHERICK, David Peter | Segretario | 12 Horncastle Close BL8 1XE Bury Lancashire | British | Accountant | 15959630001 | |||||
CHERRY, Jeffrey Scott | Segretario | Hollister Houston 6700 Texas 77040 United States | 277933840001 | |||||||
MCHARG, Cornelius Deacon | Segretario | 55 Mearns Road G76 7ES Clarkston Lanarkshire | British | 126547910001 | ||||||
MCKENNA, David Francis | Segretario | 190-192 Carlisle Road Blackwood ML11 9SB Lanark | British | Director | 104215590001 | |||||
MILLER, Andrew Arthur | Segretario | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | Director | 162220750001 | |||||
MOSS, Michael Craig | Segretario | 363 Helen Street G51 3AD Glasgow Pavillion 2 | 201739460001 | |||||||
PERRISS, Robyn | Segretario | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | Director | 97879810002 | |||||
COSEC LIMITED | Segretario nominato | 78 Montgomery Street EH7 5JA Edinburgh Lothian | 900003850001 | |||||||
HMS SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | The Ca'D'Oro 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow | 900004320001 | |||||||
AGAN, Dan Steven | Amministratore | 363 Helen Street G51 3AD Glasgow Pavillion 2 | United States | American | Business Executive | 84053880001 | ||||
BROCKMAN, Robert Theron | Amministratore | 363 Helen Street G51 3AD Glasgow Pavillion 2 | United States | American | Business Executive | 158497330001 | ||||
BROMLEY, James | Amministratore | Mill Place KT1 2RS Kingston Upon Thames 7 Surrey | British | Director | 128836230001 | |||||
BRYCE, Paul | Amministratore | 6 Hebrides Grove Inverkip Marina PA16 0BQ Inverkip | British | Director | 79519270002 | |||||
BURNETT, Robert David | Amministratore | Cumberland Street EH3 6RE Edinburgh 64a Scotland | United States | American | Business Executive | 121495910001 | ||||
CHERRY, Jeffrey Scott | Amministratore | Hollister Houston 6700 Texas 77040 United States | United States | American | General Counsel | 277917490001 | ||||
COOPER, Carlan Max | Amministratore | 363 Helen Street G51 3AD Glasgow Pavillion 2 | Usa | United States | Business Executive | 136536270001 | ||||
HIERS, William Ardis | Amministratore | 363 Helen Street G51 3AD Glasgow Pavillion 2 | United States | American | Business Executive | 201030300001 | ||||
JONES, Terry Wallace | Amministratore | 363 Helen Street G51 3AD Glasgow Pavillion 2 | United States | American | Business Executive | 84053830001 | ||||
LEWIS, Robert James | Amministratore | 363 Helen Street G51 3AD Glasgow Pavillion 2 | England | British | Company Director | 83629470002 | ||||
LEWIS, Robert James | Amministratore | 363 Helen Street G51 3AD Glasgow Pavillion 2 Scotland | England | British | Director | 83629470002 | ||||
MCGOWAN, Derek | Amministratore | 83 Old Greenock Road PA7 5BE Bishopton | Scotland | British | Director | 79519030001 | ||||
MCGOWAN, Derek | Amministratore | 83 Old Greenock Road PA7 5BE Bishopton | Scotland | British | Director | 79519030001 | ||||
MCHARG, Neil | Amministratore | 55 Mearns Road Clarkston G76 7ES Glasgow | United Kingdom | British | Director | 30993940003 | ||||
MCKENNA, David Francis | Amministratore | 190-192 Carlisle Road Blackwood ML11 9SB Lanark | British | Director | 104215590001 | |||||
MILLER, Andrew Arthur | Amministratore | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | United Kingdom | British | Director | 162220750001 | ||||
MOSS, Michael Craig | Amministratore | 363 Helen Street G51 3AD Glasgow Pavillion 2 | United States | American | Business Executive | 121496770001 | ||||
NALLEY, Robert Maxey | Amministratore | 363 Helen Street G51 3AD Glasgow Pavillion 2 | United States | American | Business Executive | 84053700001 | ||||
STOREY, Graham Neil | Amministratore | Treetops Garden Close Lane RG14 6PP Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 48939070004 | ||||
CODIR LIMITED | Amministratore delegato nominato | 78 Montgomery Street EH7 5JA Edinburgh Lothian | 900003840001 | |||||||
COSEC LIMITED | Amministratore delegato nominato | 78 Montgomery Street EH7 5JA Edinburgh Lothian | 900003850001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CONTACT ADVANTAGE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ucs Systems Limited | 06 apr 2016 | Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham 1200 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Ucs Systems Limited | 06 apr 2016 | Bristol Road South Northfield B31 2RW Birmingham 1200 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CONTACT ADVANTAGE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Bond & floating charge | Creato il 07 dic 2007 Consegnato il 17 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 27 ago 2003 Consegnato il 16 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0