STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED

STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC225035
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KPMG LLP
    Saltire Court,
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HALLADALE VENTURES (SCOTLAND) LIMITED25 feb 200225 feb 2002
    PACIFIC SHELF 1097 LIMITED07 nov 200107 nov 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    4 pagine4.26(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da 151 West George Street Glasgow G2 2JJ Scotland in data 07 ago 2012

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 02 ago 2012

    LRESSP

    Cessazione della carica di Stuart Andrew Weir Duncan come segretario in data 27 giu 2012

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 nov 2011

    Stato del capitale al 22 nov 2011

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 180 st. Vincent Street Glasgow G2 5SG United Kingdom in data 25 ott 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 giu 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 giu 2009

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Alan Macleod come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Alan Donald Ewen Macleod il 09 nov 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    16 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed halladale ventures (scotland) LIMITED\certificate issued on 30/06/08
    2 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARKIN, Mark James
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    Amministratore
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    Scotland UkBritishDirector42293490004
    LINDSAY, Kenneth Fraser
    61 Muir Wood Crescent
    Currie
    EH14 5HB Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    61 Muir Wood Crescent
    Currie
    EH14 5HB Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishProperty Director121520410001
    DUNCAN, Stuart Andrew Weir
    16 Woodlands Terrace
    G3 6DF Glasgow
    Segretario
    16 Woodlands Terrace
    G3 6DF Glasgow
    BritishSolicitor80233100002
    HARKIN, Mark James
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    Segretario
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    BritishFinance Director42293490004
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Segretario nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritishBank Executive68241910003
    GATELEY, Donald Kenneth
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    Amministratore
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    United KingdomBritishBanker104442220001
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    Amministratore
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritishBanking Official113081830001
    LOCKHART, David Alfred Stevenson
    5 Carlton Terrace
    EH7 5DD Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 Carlton Terrace
    EH7 5DD Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishDirector35520610001
    MACKINTOSH, Iain Stewart
    90 Flat 2 Mayfield Road
    Newington
    EH9 2NJ Edinburgh
    Amministratore
    90 Flat 2 Mayfield Road
    Newington
    EH9 2NJ Edinburgh
    BritishChartered Accountant80118270001
    MACLEOD, Alan Donald Ewen
    12 Violet Terrace
    EH11 1NZ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    12 Violet Terrace
    EH11 1NZ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishChartered Accountant107116780001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 03 feb 2006
    Consegnato il 17 feb 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all present and future estates or interests in any freehold or leasehold property now or in the future belonging to it and located in england or wales (see attached schedule) including fixed and floating charges.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 03 feb 2006
    Consegnato il 16 feb 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Supplemental debenture
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 14 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    First legal mortgage over freehold land at 73-75 the strand, london NGL408757.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 14 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Deed of accession
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 14 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    First legal mortgage over freehold land at 73-75 the strand, london NGL408757.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 14 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 15 mag 2002
    Consegnato il 29 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document
    Brevi particolari
    Subjects known as the bargarren centre, barrhill road, erskine (title number REN34783).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 15 mag 2002
    Consegnato il 29 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document
    Brevi particolari
    Subjects known as 6/14 church street and 6 baron taylor's street, inverness together with buildings and erections thereon and right, title and interest.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 15 mag 2002
    Consegnato il 29 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document
    Brevi particolari
    Subjects known as 22 and 24 cambridge street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 15 mag 2002
    Consegnato il 29 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document
    Brevi particolari
    The tenant's interest in the lease over subjects known as 158-204 main street, barrhead.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 08 mag 2002
    Consegnato il 17 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document
    Brevi particolari
    Gross rental income over 22 and 24 cambridge street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 08 mag 2002
    Consegnato il 17 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document
    Brevi particolari
    The gross rental income over the tenant's interest in 158-204 main street, barrhead.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 08 mag 2002
    Consegnato il 17 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document
    Brevi particolari
    The gross rental income over 6/14A church street and 6 baron taylor's street, inverness.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 08 mag 2002
    Consegnato il 17 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document
    Brevi particolari
    The gross rental income over the barrangate centre, barhill road, erskine.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 08 mag 2002
    Consegnato il 17 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under the finance documents
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)

    STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 set 2013Data di scioglimento
    02 ago 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Blair Carnegie Nimmo
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Praticante
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0