ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED

ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàANNFIELD INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC228989
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Dove si trova ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Maclay Murray & Spens Quartermile One
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KILMARTIN INVESTMENTS LIMITED02 apr 200202 apr 2002
    KILMARTIN SECURITIES LIMITED11 mar 200211 mar 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    3 pagine4.26(Scot)

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 giu 2011

    LRESSP

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2010 al 31 mar 2011

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 11 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 mar 2011

    Stato del capitale al 16 mar 2011

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Mrs Susan Elizabeth Groat come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Susan Groat come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG03s

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    15 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH in data 03 giu 2010

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 11 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    29 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Gordon Bennet come amministratore

    2 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    29 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Nomina di Gordon Iain Bennet come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Susan Elizabeth Groat come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Wotherspoon come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neil Mcguinness come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    5 pagine410(Scot)

    Chi sono gli amministratori di ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GROAT, Susan Elizabeth
    George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    93
    United Kingdom
    Amministratore
    George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    93
    United Kingdom
    ScotlandBritish88980540001
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Segretario
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Segretario nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BENNET, Gordon Iain
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    Dunbartonshire
    Amministratore
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    Dunbartonshire
    United KingdomBritish60009740002
    GROAT, Susan Elizabeth
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    Amministratore
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    ScotlandBritish88980540001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Amministratore
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    United KingdomBritish83466350002
    MITCHELL, David Frank Robert
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Amministratore
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    British97869190001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Amministratore
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish161858620001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 19 ago 2009
    Consegnato il 26 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    8 to 14 young street lane north & garage at 24 young street lane north, edinburgh MID103259.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 16 apr 2008
    Consegnato il 24 apr 2008
    In corso
    Importo garantito
    All obligations undertaken to the creditor in terms of a clawback agreement dated 04/04/08
    Brevi particolari
    4 storey tenement on the west side of rose street lane north, edinburgh located to the rear of 29/31 frederick street, edinburgh MID115164.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 31 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Standard security
    Creato il 18 ott 2006
    Consegnato il 21 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    114 princes street, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 27 apr 2006
    Consegnato il 05 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    116 princes street, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 28 mar 2006
    Consegnato il 05 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond dated 22 march 2006
    Brevi particolari
    The ground and basement floors known as 162 union street, aberdeen (title number ABN8016).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 24 mar 2006
    Consegnato il 12 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    3.015 and 3.069 acres at greenwell road, east tullos industrial estate, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 02 feb 2006
    Consegnato il 15 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The leasehold property known as land and buildings at parkhouse east industrial estate newcastle under lyme.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 06 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    292/294 st vincent street and 125/127 pitt street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 16 set 2005
    Consegnato il 27 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land at the junction of the A19 and A689 wynyard hall, billingham, stockton on tees.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 set 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 12 lug 2005
    Consegnato il 18 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The subjects comprising 45-57 high street, leven (title number FFE39252).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 10 giu 2005
    Consegnato il 17 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all the freehold property known as spring lane, andover, hampshire (title number HP564907); fixed and floating charges over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 apr 2005
    Consegnato il 05 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    7 castle street, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Floating charge
    Creato il 05 apr 2005
    Consegnato il 08 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over leasehold property known as land and buildings on the north side of sanderson street, newcastle upon tyne TY245732.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 13 ago 2004
    Consegnato il 19 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    4/8 frances street, stornoway.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 13 ago 2004
    Consegnato il 19 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    54 & 56 princes street, port glasgow REN70658.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 13 ago 2004
    Consegnato il 19 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    40 main street & 7 mill street, rutherglen LAN113712.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 13 ago 2004
    Consegnato il 19 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    98,100 & 102 dockhead street, saltcoats AYR23986.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 13 ago 2004
    Consegnato il 19 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    34 glaisnock street, cumnock AYR17072.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 13 ago 2004
    Consegnato il 19 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    7 tryst road & 48 king street, stenhousemuir, larbert STG19470.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 13 ago 2004
    Consegnato il 19 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    102 argyll street, dunoon ARG5229.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 apr 2004
    Consegnato il 07 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of a personal bond dated 15 march 2004
    Brevi particolari
    The subjects known as and forming 22-24 cambridge street, glasgow (title number gla 47546).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 24 mar 2004
    Consegnato il 01 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over land north east of nunnery drive, sheffield SYK266684.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 04 ago 2003
    Consegnato il 06 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond dated 28 july 2003
    Brevi particolari
    The subjects known as and forming 1 and 2 pitt terrace, stirling (title number STG7997).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 mag 2003
    Consegnato il 22 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of a personal bond dated 28 april 2003
    Brevi particolari
    The subjects comprising the shop units on the ground and basement floors (and mezzanine level between) forming 178, 180, 182 and 186 trongate, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 mag 2012Data di scioglimento
    15 giu 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0