COLERIDGE (NO.3) LIMITED

COLERIDGE (NO.3) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOLERIDGE (NO.3) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC229627
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COLERIDGE (NO.3) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova COLERIDGE (NO.3) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1st Floor Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COLERIDGE (NO.3) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per COLERIDGE (NO.3) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per COLERIDGE (NO.3) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    43 pagine4.26(Scot)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Valsec Director Limited il 01 lug 2013

    2 pagineCH02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Fraser James Kennedy il 01 lug 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 apr 2013

    Stato del capitale al 04 apr 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2012

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Fraser James Kennedy il 05 nov 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    25 pagineMG01s

    Risoluzioni

    Resolutions
    10 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Documents approved 20/03/2012
    RES13

    legacy

    9 pagineMG01s

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 09 dic 2010

    3 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da Exchange Place 3 3 Semple Street Edinburgh EH3 8BL in data 08 dic 2010

    2 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 giu 2010

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COLERIDGE (NO.3) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Segretario
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC219311
    133355520001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountantq121610350003
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5307786
    102622300002
    BLAIN, Andrew John
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Segretario
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    BritishSolicitor40585290002
    BROOK, Susan Margaret
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    Segretario
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    British72328070001
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Segretario
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    BLAIN, Andrew John
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Amministratore
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    ScotlandBritishSolicitor40585290002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishSolicitor1267050001
    KENNEDY, Claire Michelle
    Flat 3f2
    2 Brunswick Place
    EH7 5HP Edinburgh
    Amministratore
    Flat 3f2
    2 Brunswick Place
    EH7 5HP Edinburgh
    BritishTrainee Solicitor81040630001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    BritishSurveyor109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector135717740001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBanker106197810002
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Amministratore
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritishChartered Accountant41925000003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Amministratore
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritishDirector69909950001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    COLERIDGE (NO.3) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond & floating charge
    Creato il 23 mar 2012
    Consegnato il 29 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 19 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 mar 2012
    Consegnato il 02 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 19 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Accession deed to guarantee and debenture
    Creato il 28 ago 2009
    Consegnato il 07 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Accession agreement and charge
    Creato il 28 ago 2009
    Consegnato il 04 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 23 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 23 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the freehold property known as units 2-10 solent road industrial estate, havant, hampshire; fixed charges over assets; flaoting charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 23 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All the freehold property known as units 1-4, 160 the marlowes, waterhouse street, hemel hempstead; fixed charges over assets; flaoting charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 23 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the property known as 20-22 tudor street, london; fixed charges over assets; flaoting charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 23 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the property known as southernhay gardens estate, exeter; fixed charges over assets; flaoting charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 23 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all the freehold property known as the land on the south side of bristol road, gloucester known as ashville indsutrial estate; fixed charges over assets; flaoting charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 23 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the freehold property known as land at corner hall (brunel court, cligfton court, brindley house and telford house) hemel hempstead; fixed charges over assets; flaoting charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 23 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all the freehold property on the north side of albert road, blackpool known as the eden centre, bank hey street, blackpool; fixed charges over assets; flaoting charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 23 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the property known as 110-132 high street, hounslow and land lying to the north of high street, hounslow; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    COLERIDGE (NO.3) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 ott 2013Inizio della liquidazione
    24 feb 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0