COLERIDGE (NO. 5) LIMITED

COLERIDGE (NO. 5) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOLERIDGE (NO. 5) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC230325
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COLERIDGE (NO. 5) LIMITED?

    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova COLERIDGE (NO. 5) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1st Floor Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COLERIDGE (NO. 5) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per COLERIDGE (NO. 5) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato)

    15 pagineLIQ13(Scot)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 07 gen 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere SC2303250020 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC2303250021 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC2303250022 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 giu 2017

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 apr 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Valsec Director Limited il 24 feb 2017

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 24 feb 2017

    1 pagineCH04

    Nomina di Mr James Edward Maddy come amministratore in data 24 feb 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Kenneth Robertson come amministratore in data 24 feb 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    26 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca SC2303250022, creata il 16 dic 2016

    71 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca SC2303250021, creata il 16 dic 2016

    26 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca SC2303250020, creata il 16 dic 2016

    21 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 18 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di COLERIDGE (NO. 5) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Segretario
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC219311
    133355520004
    MADDY, James Edward
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish137459000002
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5307786
    102622300003
    BLAIN, Andrew John
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Segretario
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    British40585290002
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Segretario
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    BLAIN, Andrew John
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Amministratore
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    ScotlandBritish40585290002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    KENNEDY, Claire Michelle
    Flat 3f2
    2 Brunswick Place
    EH7 5HP Edinburgh
    Amministratore
    Flat 3f2
    2 Brunswick Place
    EH7 5HP Edinburgh
    British81040630001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish121610350003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House, 20
    North Yorkshire
    Amministratore
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House, 20
    North Yorkshire
    EnglandBritish135717740001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106197810002
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Amministratore
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Amministratore
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish189529610001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    Chi sono le persone con controllo significativo di COLERIDGE (NO. 5) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Philip Lawrence Turpin
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Jersey
    17 mag 2017
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Jersey
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Jersey
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Robin Baird
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Jersey
    17 mag 2017
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Jersey
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Jersey
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Msms Nominee 1 Limited
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    England
    16 dic 2016
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    England
    Forma giuridicaCorporate
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione09282363
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    COLERIDGE (NO. 5) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 16 dic 2016
    Consegnato il 23 dic 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Freehold tenure of the land and buildings known as london court, 39 london road, reigate, RH2 9AQ registered in the land registry with title numbers SY243432 and SY712318.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 dic 2016
    Consegnato il 23 dic 2016
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 dic 2016
    Consegnato il 23 dic 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge
    Creato il 23 mar 2012
    Consegnato il 29 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Right, title and interest in the charged assets. See form for further details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Bond & floating charge
    Creato il 23 mar 2012
    Consegnato il 29 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 mar 2012
    Consegnato il 02 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Accession deed to guarantee and debenture
    Creato il 28 ago 2009
    Consegnato il 07 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Accession agreement and change
    Creato il 28 ago 2009
    Consegnato il 04 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge
    Creato il 28 ago 2009
    Consegnato il 04 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All right, title and interest in the existing shares and related rights.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 16 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all freehold property known as 5 bedford park, croydon, surrey; fixed and floating charges over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 16 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all freehold property known as 111 chertsey road, woking, surrey; fixed and floating charges over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 16 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all freehold property known as units 1 and 2 sterling court, welwyn garden city, hertfordshire; fixed and floating charges over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 16 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all freehold property known as shell house, 77 clarendon road, watford; fixed and floating charges over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 16 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all freehold property known as cedar house, 39 london road, reigate, surrey; fixed and floating charges over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 16 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over all freehold property known as charter house, 462 avebury boulevard, milton keynes; fixed and floating charges over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over contract for sale
    Creato il 07 mag 2002
    Consegnato il 18 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 in 111 chertsey road, woking, surrey; first fixed charge over assets.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Charge over contract for sale
    Creato il 07 mag 2002
    Consegnato il 18 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 in units 1 and 2 sterling court, welwyn garden city, hertfordshire; first fixed charge over assets.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over contract for sale
    Creato il 07 mag 2002
    Consegnato il 18 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 in 5 bedford park, croydon, surrey; first fixed charge over assets.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Charge over contract for sale
    Creato il 07 mag 2002
    Consegnato il 18 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 in charter house, 462 avebury boulevard, milton keynes; first fixed charge over assets.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Charge over contract for sale
    Creato il 07 mag 2002
    Consegnato il 18 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreeement dated 16 april 2002 over cedar house, 39 london road, reigate, surrey; first fixed charge over assets.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over contract for sale
    Creato il 07 mag 2002
    Consegnato il 18 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 over shell house, 77 clarendon road, watford; first fixed charge over assets.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 07 mag 2002
    Consegnato il 17 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    COLERIDGE (NO. 5) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 gen 2019Inizio della liquidazione
    16 gen 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0