COLERIDGE (NO. 5) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | COLERIDGE (NO. 5) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC230325 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COLERIDGE (NO. 5) LIMITED?
- Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari
Dove si trova COLERIDGE (NO. 5) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1st Floor Exchange Place 3 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di COLERIDGE (NO. 5) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per COLERIDGE (NO. 5) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato) | 15 pagine | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC2303250020 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC2303250021 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC2303250022 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2017 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2017 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 apr 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Valsec Director Limited il 24 feb 2017 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 24 feb 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Nomina di Mr James Edward Maddy come amministratore in data 24 feb 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Kenneth Robertson come amministratore in data 24 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2016 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca SC2303250022, creata il 16 dic 2016 | 71 pagine | MR01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca SC2303250021, creata il 16 dic 2016 | 26 pagine | MR01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca SC2303250020, creata il 16 dic 2016 | 21 pagine | MR01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 16 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 14 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 18 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 17 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 19 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di COLERIDGE (NO. 5) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh 1st Floor Exchange Place 3 United Kingdom |
| 133355520004 | ||||||||||
| MADDY, James Edward | Amministratore | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 137459000002 | |||||||||
| CROMWELL DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom |
| 102622300003 | ||||||||||
| BLAIN, Andrew John | Segretario | 60 Murrayfield Gardens EH12 6DQ Edinburgh | British | 40585290002 | ||||||||||
| RICHARDSON, Paul | Segretario | 2 Newdale Usher Park Haxby YO32 3LN York North Yorkshire | British | 60649820001 | ||||||||||
| BLAIN, Andrew John | Amministratore | 60 Murrayfield Gardens EH12 6DQ Edinburgh | Scotland | British | 40585290002 | |||||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Amministratore | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | 1267050001 | |||||||||
| KENNEDY, Claire Michelle | Amministratore | Flat 3f2 2 Brunswick Place EH7 5HP Edinburgh | British | 81040630001 | ||||||||||
| KENNEDY, Fraser James | Amministratore | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | British | 121610350003 | |||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Amministratore | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | 56953000002 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Amministratore | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||||||
| OKUNOLA, Abayomi Abiodun | Amministratore | Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House, 20 North Yorkshire | England | British | 135717740001 | |||||||||
| ROBERTSON, Ian | Amministratore | 5 Boswall Road EH5 3RH Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 106197810002 | |||||||||
| ROBERTSON, Neil Kenneth | Amministratore | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 158937210001 | |||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Amministratore | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | 41925000003 | |||||||||
| TANDY, Didier Michel | Amministratore | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | 69909950001 | |||||||||
| TREACY, Claire | Amministratore | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | 189529610001 | |||||||||
| EUROPA DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire | 102560510001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di COLERIDGE (NO. 5) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Philip Lawrence Turpin | 17 mag 2017 | Castle Street St Helier JE4 5UT Jersey 13 Jersey | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: Jersey | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr Robin Baird | 17 mag 2017 | Castle Street St Helier JE4 5UT Jersey 13 Jersey | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: Jersey | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Msms Nominee 1 Limited | 16 dic 2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
COLERIDGE (NO. 5) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 16 dic 2016 Consegnato il 23 dic 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Freehold tenure of the land and buildings known as london court, 39 london road, reigate, RH2 9AQ registered in the land registry with title numbers SY243432 and SY712318. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 16 dic 2016 Consegnato il 23 dic 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 16 dic 2016 Consegnato il 23 dic 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share pledge | Creato il 23 mar 2012 Consegnato il 29 mar 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Right, title and interest in the charged assets. See form for further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 23 mar 2012 Consegnato il 29 mar 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 mar 2012 Consegnato il 02 apr 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Accession deed to guarantee and debenture | Creato il 28 ago 2009 Consegnato il 07 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Accession agreement and change | Creato il 28 ago 2009 Consegnato il 04 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share pledge | Creato il 28 ago 2009 Consegnato il 04 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All right, title and interest in the existing shares and related rights. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 16 mag 2002 Consegnato il 25 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over all freehold property known as 5 bedford park, croydon, surrey; fixed and floating charges over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 16 mag 2002 Consegnato il 25 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over all freehold property known as 111 chertsey road, woking, surrey; fixed and floating charges over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 16 mag 2002 Consegnato il 25 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over all freehold property known as units 1 and 2 sterling court, welwyn garden city, hertfordshire; fixed and floating charges over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 16 mag 2002 Consegnato il 25 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over all freehold property known as shell house, 77 clarendon road, watford; fixed and floating charges over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 16 mag 2002 Consegnato il 25 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over all freehold property known as cedar house, 39 london road, reigate, surrey; fixed and floating charges over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 16 mag 2002 Consegnato il 25 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over all freehold property known as charter house, 462 avebury boulevard, milton keynes; fixed and floating charges over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over contract for sale | Creato il 07 mag 2002 Consegnato il 18 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 in 111 chertsey road, woking, surrey; first fixed charge over assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over contract for sale | Creato il 07 mag 2002 Consegnato il 18 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 in units 1 and 2 sterling court, welwyn garden city, hertfordshire; first fixed charge over assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over contract for sale | Creato il 07 mag 2002 Consegnato il 18 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 in 5 bedford park, croydon, surrey; first fixed charge over assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over contract for sale | Creato il 07 mag 2002 Consegnato il 18 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 in charter house, 462 avebury boulevard, milton keynes; first fixed charge over assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over contract for sale | Creato il 07 mag 2002 Consegnato il 18 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreeement dated 16 april 2002 over cedar house, 39 london road, reigate, surrey; first fixed charge over assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over contract for sale | Creato il 07 mag 2002 Consegnato il 18 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 over shell house, 77 clarendon road, watford; first fixed charge over assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 07 mag 2002 Consegnato il 17 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
COLERIDGE (NO. 5) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0