ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED

ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC232238
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED?

    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    25 St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al05 apr 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 30 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 giu 2016

    Stato del capitale al 09 giu 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Roscoe Capital Ltd 9-10 st. Andrew Square Edinburgh EH2 2AF Scotland a 125 6th Floor Princes Street Edinburgh EH2 4AD

    1 pagineAD02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 05 apr 2015

    11 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 30 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 giu 2015

    Stato del capitale al 26 giu 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 30 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 28 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 20 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 23 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 24 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 21 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 22 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 29 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ANDERSON, Dickson Brown
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    Amministratore
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    ScotlandBritishHead Of Investments7351410004
    MCMYN, Neil Armstrong
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    Amministratore
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    ScotlandBritishAccountant126304800001
    WEBBER, John David
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    Amministratore
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    United KingdomBritishDirector41493670002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Segretario
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor119269620001
    STANWORTH, William John
    Highfield House
    194 Main Street
    EH37 5SG Pathhead
    Midlothian
    Segretario
    Highfield House
    194 Main Street
    EH37 5SG Pathhead
    Midlothian
    British41736370002
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003420001
    BROOK, Robert William Middleton
    Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    22
    Midlothian
    Amministratore
    Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    22
    Midlothian
    United KingdomBritishNone149783170001
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Amministratore
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritishChartered Accountant462890002
    HEDDERWICK, Alexander Mark
    Gifford Bank
    Edinburgh Road
    EH41 4JE Gifford
    East Lothian
    Amministratore
    Gifford Bank
    Edinburgh Road
    EH41 4JE Gifford
    East Lothian
    United KingdomBritishDirector89989960001
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Amministratore
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritishManaging Director71043680001
    MORGAN, Harry James
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    Amministratore
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    United KingdomBritishFund Manager103806200002
    MORRIS, Philip Taylor
    4 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Scotland
    Amministratore
    4 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Scotland
    BritishCompany Director35386590001
    MULLIGAN, Andrew Kyle
    186 Cockburn Crescent
    Balerno
    EH14 7LU Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    186 Cockburn Crescent
    Balerno
    EH14 7LU Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishFinance Director161603300002
    ROBSON, Ronald Alexander
    19 Glasclune Gardens
    EH39 4RB North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    19 Glasclune Gardens
    EH39 4RB North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritishChartered Accountant104673590001
    REYNARD NOMINEES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore delegato nominato
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900011050001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore delegato nominato
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003410001

    ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignation of rents
    Creato il 17 gen 2006
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The assignor assigns all right, title and interest in and to the rental income in respect of the property known as dundyvan industrial estate, coatbridge lan 102640.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rents
    Creato il 17 gen 2006
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The assignor assigns all right, title and interest in and to the rental income in respect of the property known as auchinraith industrial estate, blantyre lan 22075.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rents
    Creato il 17 gen 2006
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The assignor assigns all right, title and interest in and to the rental income in respect of the property known as new albion industrial estate, glasgow gla 108239.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 29 dic 2005
    Consegnato il 10 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Auchinraith industrial estate, blantyre LAN22075.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transazioni
    • 10 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 29 dic 2005
    Consegnato il 10 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Dundyvan industrial estate, coatbridge LAN102640.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transazioni
    • 10 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 29 dic 2005
    Consegnato il 10 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    New albion industrial estate, glasgow GLA108239.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transazioni
    • 10 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 29 dic 2005
    Consegnato il 10 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Starlaw business park, livingston WLN24067.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transazioni
    • 10 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 23 nov 2004
    Consegnato il 26 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    First legal mortgage over unit 2A stephenson road, stephenson industrial estate, washington, tyne & wear (title number TY316197).
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transazioni
    • 26 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 29 set 2004
    Consegnato il 07 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    First fixed charge over freehold land south of nelson street and hulland street, derby DY342778.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transazioni
    • 07 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 11 ago 2004
    Consegnato il 17 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities under each finance document
    Brevi particolari
    First legal mortgage over all that freehold land and buildings known as land on the south east side of prince charlie street, oldham (title number GM528355).
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 17 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 22 gen 2004
    Consegnato il 30 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Units 1,2 & 3 whitley road retail park, whitley road, longbenton, newcastle TY284972 TY183940 TY300974 TY176297 TY188764.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transazioni
    • 30 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 23 ott 2003
    Consegnato il 03 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    (One) subjects comprising (a) area of ground on the south side of cunningham road and (b) area of ground on the east side of munro road, springkerse industrial estate, stirling--title number STG17431 (two) subjects known as unit 11, 20 munro road, stirling--title number STG25280 (three) tenant's interest in the lease under title number STG17266.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 03 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rents
    Creato il 09 ott 2003
    Consegnato il 20 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All right, title and interest over blocks 1-5 springkerse industrial estate, stirling.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 20 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 22 set 2003
    Consegnato il 06 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Retail warehouse site at whistleberryroad, hamilton LAN106225.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee
    Transazioni
    • 06 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rents
    Creato il 18 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Rental income over focus diy unit, whistleberry road, blantyre, dunfermline.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 26 ago 2003
    Consegnato il 09 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Marina court, castel street, kingston upon hull HS188460.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transazioni
    • 09 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 17 lug 2003
    Consegnato il 24 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or pursuant to the credit agreement dated 20 december 2002 and each finance document referred to as such in the credit agreement
    Brevi particolari
    0.100 hectares of ground comprising the office block or building with car parking pertaining thereto known as and forming cromarty house, 67-72 regent quay, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 24 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rents
    Creato il 15 lug 2003
    Consegnato il 18 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or pursuant to the credit agreement and each finance document
    Brevi particolari
    Right, title and interest in and to the rental income.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 18 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rents
    Creato il 07 lug 2003
    Consegnato il 09 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The assignor assigns all right, titlr and interst in and to the rental income as security for the secured liabilities.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 09 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 03 lug 2003
    Consegnato il 15 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or pursuant to a credit agreement dated 20 december 2002 and each finance document
    Brevi particolari
    The subjects known as the academy centre, belmont street, aberdeen (title number ABN5021).
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 15 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 24 giu 2003
    Consegnato il 11 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Kingsway shopping centre, frome, somerset.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transazioni
    • 11 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 24 giu 2003
    Consegnato il 11 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    31-34 high street, tewkesbury.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transazioni
    • 11 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 24 giu 2003
    Consegnato il 11 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    80-84(Even) town centre, the common, hatfield.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transazioni
    • 11 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 24 giu 2003
    Consegnato il 11 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    79-85(Odd numbers) humberston gate, leicester title no.LT339649.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transazioni
    • 11 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge
    Creato il 23 giu 2003
    Consegnato il 11 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under each finance document
    Brevi particolari
    The scheduled securities and all rights derived from the shares.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 11 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0