TOUCH BIONICS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TOUCH BIONICS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC232512 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TOUCH BIONICS LIMITED?
- Fabbricazione di strumenti e forniture medico-chirurgiche (32500) / Industrie manifatturiere
Dove si trova TOUCH BIONICS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Integration House Alba Business Park EH54 7EG Livingston West Lothian Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TOUCH BIONICS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TOUCH BIONICS PLC | 02 ott 2014 | 02 ott 2014 |
| TOUCH BIONICS LIMITED | 13 giu 2014 | 13 giu 2014 |
| TOUCH EMAS LIMITED | 07 giu 2002 | 07 giu 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TOUCH BIONICS LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TOUCH BIONICS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 30 giu 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 14 lug 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 30 giu 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per TOUCH BIONICS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio redatto al 31 dic 2024 | 31 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Sveinn Solvason il 11 apr 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tomas Eiriksson come amministratore in data 08 apr 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Guðný Arna Sveinsdóttir come amministratore in data 08 apr 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 30 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 30 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Ossur Uk Holding Limited come persona con controllo significativo il 28 giu 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Ossur Uk Holding Limited come persona con controllo significativo il 04 nov 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 32 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio modificato di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2020 | 29 pagine | AAMD | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 34 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Theodorus Joseph Lambertus Wilhelmus Van Poorten come amministratore in data 01 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jon Sigurosson come amministratore in data 01 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hugh Gill come amministratore in data 01 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Tomas Eiriksson come amministratore in data 01 apr 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020 | 15 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TOUCH BIONICS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLVASON, Sveinn Logi | Amministratore | Alba Business Park EH54 7EG Livingston Integration House West Lothian Scotland | Iceland | Icelandic | 207109890002 | |||||||||||||
| SVEINSDÓTTIR, Guðný Arna | Amministratore | 109 Reykjavík Akrasel 16 Iceland | Iceland | Icelandic | 334554540001 | |||||||||||||
| KING, Susan | Segretario | 8 Buckstone Row EH10 6TP Edinburgh | British | 82365770001 | ||||||||||||||
| MACKEAN, Robert Mackintosh | Segretario | 10a Dick Place EH9 2JL Edinburgh | British | 37456310002 | ||||||||||||||
| MCGREGOR, Jill Amanda | Segretario | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | 191434580001 | |||||||||||||||
| REYNARD, Martin, Dr | Segretario | Station Road EH27 8BJ Kirknewton The Old Schoolhouse West Lothian Uk | British | 131537440001 | ||||||||||||||
| BRODIES SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh 15 Scotland |
| 79799970001 | ||||||||||||||
| BURNESS LLP | Segretario | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland |
| 99448920001 | ||||||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||||||||||
| ALLAN, Sandy | Amministratore | c/o Scottish Health Innovations Ltd Vincent Street G2 5SG Glasgow 206 Scotland | United Kingdom | British | 131641960001 | |||||||||||||
| BORTHWICK, George Cooper, Professor | Amministratore | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Scotland | British | 9509780001 | |||||||||||||
| BROWN, John, Dr | Amministratore | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Scotland | British | 190745120001 | |||||||||||||
| CADENHEAD, Lynne | Amministratore | 49 Castle Gate G71 7HU Bothwell | Scotland | British | 87524030001 | |||||||||||||
| EIRIKSSON, Tomas | Amministratore | Alba Business Park EH54 7EG Livingston Integration House West Lothian Scotland | Iceland | Icelandic | 294989330001 | |||||||||||||
| FORD, Mark William | Amministratore | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Usa | American | 138542690001 | |||||||||||||
| FORD, Mark William | Amministratore | Gordon Road 45335 Jamestown 1800 Greene County Usa | Usa | American | 138542690001 | |||||||||||||
| GILL, Hugh | Amministratore | Alba Business Park EH54 7EG Livingston Integration House West Lothian Scotland | United Kingdom | British | 79680760001 | |||||||||||||
| GILL, Hugh | Amministratore | 22 Redhurst Way Gleniffer Gate PA2 8PY Paisley | United Kingdom | British | 79680760001 | |||||||||||||
| GILLIES, Crawford Scott | Amministratore | 12 Heriot Row EH3 6HP Edinburgh Midlothian | British | 42352800002 | ||||||||||||||
| GOW, David James | Amministratore | 33 Fox Spring Rise EH10 6NE Edinburgh Midlothian | British | 75967370001 | ||||||||||||||
| GRANT, John Albert Martin | Amministratore | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | England | British | 55161940001 | |||||||||||||
| GRANT, John Albert Martin | Amministratore | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | England | British | 55161940001 | |||||||||||||
| MACDONALD, Cameron Mackay | Amministratore | 10 Paxton Close MK46 5PR Olney Buckinghamshire | England | British | 56171470001 | |||||||||||||
| MACKEAN, Robert Mackintosh | Amministratore | 10a Dick Place EH9 2JL Edinburgh | Scotland | British | 37456310002 | |||||||||||||
| MCBEATH, David George | Amministratore | Carwinshoch Carrick Riggs KA7 4LB Ayr | British | 68030880002 | ||||||||||||||
| MCGILL, Colin Scott | Amministratore | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | United Kingdom | British | 663080001 | |||||||||||||
| MCGREGOR, Jill Amanda | Amministratore | Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston 3 Ashwood Court United Kingdom | United Kingdom | British | 160432920002 | |||||||||||||
| MEAD, Stuart Edgar | Amministratore | 2 Bury Farm Potter Row HP16 9LU Great Missenden Buckinghamshire | England | British | 98961660001 | |||||||||||||
| MISHRA, Gaurav | Amministratore | Whitacres G53 7LJ Glasgow 56 Lanarkshire Uk | Indian | 134290810001 | ||||||||||||||
| NEWMAN, Philip James | Amministratore | 74 Lye Green Road HP5 3NB Chesham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 13755770004 | |||||||||||||
| PASSERO, Thomas | Amministratore | Kelly Road, PO BOX 82 NY 12740 Grahamsville 47 New York United States | Other | 131854840001 | ||||||||||||||
| PATTULLO, Robert Michael | Amministratore | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Scotland | British | 54596190001 | |||||||||||||
| REYNARD, Martin, Dr | Amministratore | Station Road EH27 8BJ Kirknewton The Old Schoolhouse West Lothian Uk | United Kingdom | British | 131537440001 | |||||||||||||
| SIGUROSSON, Jon | Amministratore | Alba Business Park EH54 7EG Livingston Integration House West Lothian Scotland | United States | Icelandic | 207109850001 | |||||||||||||
| STEVENS, Ian Herbert | Amministratore | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Scotland | British | 148952800001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TOUCH BIONICS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossur Uk Holding Limited | 11 apr 2016 | Hamilton Road SK1 2AE Stockport Unit No. 1 S. Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0