NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED

NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC238098
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    2nd Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NPFI MANAGEMENT LIMITED19 dic 200219 dic 2002
    NPFI ASSET MANAGEMENT LIMITED07 nov 200207 nov 2002
    MM&S (2932) LIMITED14 ott 200214 ott 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 14 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 ott 2015

    Stato del capitale al 30 ott 2015

    • Capitale: GBP 80.2
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    48 pagineAA

    Nomina di Mr Jonathan Peter Doberman come amministratore in data 04 set 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nestor Augusto Castillo Borrero come amministratore in data 04 set 2015

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Biif Corporate Services Limited il 01 lug 2015

    1 pagineCH02

    Bilancio annuale redatto al 14 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 nov 2014

    Stato del capitale al 06 nov 2014

    • Capitale: GBP 80.2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    9 pagineAA

    Nomina di Mr Nestor Augusto Castillo Borrero come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Forrest come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Forrest il 21 mag 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Forrest il 11 nov 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 14 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ott 2013

    Stato del capitale al 28 ott 2013

    • Capitale: GBP 80.2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Forrest il 09 ott 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Forrest il 01 giu 2012

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Infrastructure Managers Ltd 2Nd Floor 11 Thistle Street Edinburgh EH2 1DF* in data 27 ago 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    13 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Biif Corporate Services Limited il 04 set 2012

    2 pagineCH02

    Dettagli del direttore cambiati per Biif Corporate Services Limited il 04 set 2012

    2 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Infrastructure Managers Limited il 26 feb 2013

    2 pagineCH04

    Bilancio annuale redatto al 14 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Biif Corporate Services Limited il 04 set 2012

    2 pagineCH02

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione05372427
    128530180002
    DOBERMAN, Jonathan Peter
    Palace Street
    SW1E 5JD London
    16
    United Kingdom
    Amministratore
    Palace Street
    SW1E 5JD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritish201234400001
    BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Amministratore
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06793845
    138240210001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Segretario nominato
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Segretario
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    NOBLE PARTNERSHIP LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Segretario
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    86014010001
    BARKER, Jeremy Robert
    41 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    Amministratore
    41 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    British87277640001
    CASTILLO BORRERO, Nestor Augusto
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    EnglandBritish182601420001
    CHAPLIN, Robert Henry Moffett
    23 Moray Place
    EH3 6DA Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    23 Moray Place
    EH3 6DA Edinburgh
    Lothian
    United KingdomBritish63131640001
    CLARKE, Laurence Seymour
    Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc, 1
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc, 1
    EnglandBritish138241960001
    FORREST, Michael
    c/o Infrastructure Managers Limited
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    Amministratore
    c/o Infrastructure Managers Limited
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United KingdomBritish169634490002
    MCCULLOCH, Paul
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    Amministratore
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    British101810930001
    MCDONAGH, John
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    Amministratore
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    British116580030002
    MIDDLETON, Nigel Wythen
    The Cottage
    198 High Molewood
    SG14 2PJ Hertford
    Amministratore
    The Cottage
    198 High Molewood
    SG14 2PJ Hertford
    United KingdomBritish85320540001
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    Amministratore
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    British41327480001
    PHILIPSZ, Joseph Eugene
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish,Irish83107910002
    RAY, Alastair Graham
    Flat 120, Globe Wharf
    205, Rotherhithe Street
    SE16 5EQ London
    Amministratore
    Flat 120, Globe Wharf
    205, Rotherhithe Street
    SE16 5EQ London
    British100818970001
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Amministratore
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    SCOTT-BARRETT, Nicholas Huson
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    Amministratore
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    British59658050001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    NPFI MANAGEMENT (2038) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond & floating charge
    Creato il 28 lug 2011
    Consegnato il 16 ago 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Charge over securities
    Creato il 28 lug 2011
    Consegnato il 16 ago 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all of its present and future right title and interest in and to the following assets: all securities and all related rights and all propety and rights.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Deed of confirmation to charge over shares
    Creato il 19 dic 2007
    Consegnato il 28 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The charging company, in security for the payment or discharge of the secured liabilities, charges and agrees to charge by way of a first charge all the shares together with the related rights from time to time accruing to those shares - see form 410 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 19 dic 2007
    Consegnato il 28 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Deed of confirmation to charge over shares
    Creato il 09 nov 2007
    Consegnato il 22 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    First charge over all shares together with related rights.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 09 nov 2007
    Consegnato il 22 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 04 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Supplemental agreement to charge over shares
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    First charge over all the shares and related rights accruing to those shares.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Charge over shares
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 13 gen 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The charging company, in security for the payment or discharge of the secured liabilities, charges and aggrees to charge by way of a first fixed charge all the shares together with the related rights from time to time accruing to those shares.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Bond & floating charge
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 07 gen 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 gen 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 28 nov 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 28 dic 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • Ha modifiche ai divieti

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0