YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàYOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC245072
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wheatley House, 25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Glasgow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GHA (MANAGEMENT) LIMITED05 mar 200305 mar 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2023

    2 pagineAA

    Nomina di Mrs Josephine Armstrong come amministratore in data 02 giu 2023

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2023 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2021

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Sheila Margaret Gunn come amministratore in data 29 set 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Elizabeth Mary Walford come amministratore in data 29 set 2021

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere SC2450720002 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC2450720004 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC2450720003 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    18 pagineAA

    Nomina di Mr Steven John Henderson come amministratore in data 30 set 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elaine Melrose come amministratore in data 30 set 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 mar 2020 senza aggiornamenti

    2 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael Mccabe come amministratore in data 25 set 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 mar 2019 senza aggiornamenti

    2 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca SC2450720002, creata il 30 ott 2018

    21 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALLISON, Anthony
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Scotland
    Segretario
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Scotland
    224595300001
    ARMSTRONG, Josephine
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Amministratore
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritishEconomist121182240003
    HENDERSON, Steven John
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Amministratore
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritishGroup Director Of Finance188575210001
    CRAIG, Kirsten Mary
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Scotland
    Segretario
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Scotland
    British188422900001
    HENDERSON, Julia Anne
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Segretario
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    British151777670001
    LENNON, Michael Andrew
    3 Ashton Road
    G12 8SP Glasgow
    Segretario
    3 Ashton Road
    G12 8SP Glasgow
    British94455270001
    LOGAN, Mark Gerard
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Segretario
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    British160706540001
    MOIR, Gordon Ivor
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Segretario
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    British150776680001
    STEVENSON, Donna Lesley
    142 Hyndland Road
    G12 9PN Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    142 Hyndland Road
    G12 9PN Glasgow
    Lanarkshire
    British100054160002
    T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Segretario
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    64631620001
    BLYTH, William Michael
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Amministratore
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritishAccounting Firm Partner173115270001
    DEANS, Colin Stirling
    Flat 21 5 Birness Drive
    G43 1TA Glasgow
    Amministratore
    Flat 21 5 Birness Drive
    G43 1TA Glasgow
    ScotlandBritishRetired103983110001
    DILLON, Margaret Jean
    133 Caldarvan Street
    G22 5RG Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    133 Caldarvan Street
    G22 5RG Glasgow
    Lanarkshire
    UkBritishRetired67916130001
    DOUGAN, Elizabeth
    2 Taylor Place
    Townhead
    G4 0PA Glasgow
    Amministratore
    2 Taylor Place
    Townhead
    G4 0PA Glasgow
    Great BritainBritishRetired86590460001
    FURY, John Gerard
    25 Walnut Road
    G22 6EU Glasgow
    Amministratore
    25 Walnut Road
    G22 6EU Glasgow
    BritishRetired95858230001
    FYFE, Maria
    10 Ascot Avenue
    G12 0AX Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    10 Ascot Avenue
    G12 0AX Glasgow
    Lanarkshire
    BritishRetired90275680001
    GOLDIE, John
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Amministratore
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritishRetired80585870001
    GUNN, Sheila Margaret
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Amministratore
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    United KingdomBritishConsultant/ Non Executive Director52725500002
    HASTIE, John
    House 96 40 Dumbreck Court
    G20 9HE Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    House 96 40 Dumbreck Court
    G20 9HE Glasgow
    Lanarkshire
    BritishRetired111668800001
    ISDALE, Graham
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Amministratore
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    United KingdomBritishExecutive Director163723820001
    LEONARD, Gerald Richard, Bailie
    178 Briarcroft Road
    G33 1RH Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    178 Briarcroft Road
    G33 1RH Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCouncillor66744820001
    LOGAN, Mark Gerard
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Amministratore
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritishFinance Director47812710004
    LOGAN, Mark Gerard
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Amministratore
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritishFinance Director47812710004
    MASON, Christopher Michael, Dr.
    25 Braidholm Road
    G46 6HS Giffnock
    East Renfrewshire
    Amministratore
    25 Braidholm Road
    G46 6HS Giffnock
    East Renfrewshire
    United KingdomBritishCouncillor105452470001
    MASTERTON, Williamina
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Amministratore
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritishRetired100910850001
    MASTERTON, Williamina
    50 Beil Drive
    Yoker
    G13 4DB Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    50 Beil Drive
    Yoker
    G13 4DB Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishUnemployed100910850001
    MCCABE, Michael
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Amministratore
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritishHouseing Association Director154804360001
    MCEWING, Isabel
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRetired100910990001
    MCEWING, Isabel
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRetired100910990001
    MCGUIRE, Alexander Serrels
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Amministratore
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    United KingdomBritishHousing Association Director154804060001
    MCKINVEN, John
    598 Boydstone Road
    Carnwadric
    G46 8NF Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    598 Boydstone Road
    Carnwadric
    G46 8NF Glasgow
    Lanarkshire
    BritishRetired102007460001
    MCVICAR, John
    58 Leighton Street
    High Ruchill
    G20 9HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    58 Leighton Street
    High Ruchill
    G20 9HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Great BritainBritishNone120516560001
    MELROSE, Elaine
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Amministratore
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritishGroup Director Of Resources208961820001
    RYAN, George
    Hamilton Road
    Mount Vernon
    G32 9QQ Glasgow
    226
    Amministratore
    Hamilton Road
    Mount Vernon
    G32 9QQ Glasgow
    226
    UkBritishCouncillor133071420001
    SHEDDEN, Alfred Charles
    17 Beaumont Gate
    G12 9ED Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    17 Beaumont Gate
    G12 9ED Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director1213170002

    Chi sono le persone con controllo significativo di YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    25 Wheatley House
    Scotland
    06 apr 2016
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    25 Wheatley House
    Scotland
    No
    Forma giuridicaCompany Ltd By Guarantee
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc426094
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 ott 2018
    Consegnato il 06 nov 2018
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties as Defined in the Instrument Accompanying This Form MR01
    Transazioni
    • 06 nov 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 ott 2018
    Consegnato il 06 nov 2018
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties as Defined in the Instrument Accompanying This Form MR01
    Transazioni
    • 06 nov 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 ott 2018
    Consegnato il 06 nov 2018
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties as Defined in the Instrument Accompanying This Form MR01
    Transazioni
    • 06 nov 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Bond & floating charge
    Creato il 22 dic 2003
    Consegnato il 08 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in respect of the gha liabilities and all obligations under any of the relevant documents
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0