RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC245357 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 5th Floor 7 Castle Street EH2 3AH Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| APPLY ALTRA LIMITED | 17 mag 2011 | 17 mag 2011 |
| ALTRA ENERGY LIMITED | 10 mar 2003 | 10 mar 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Jens Rebsdorf-Gregersen come amministratore in data 11 feb 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lars Krogh come amministratore in data 11 feb 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Sovereign House 158 West Regent Street Glasgow G2 4RL Scotland a 5th Floor 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH in data 10 feb 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy James Cunningham come segretario in data 20 giu 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Charles Thorp come segretario in data 20 giu 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 158 Sovereign House 158 West Regent Street Glasgow G2 4RL Scotland a Sovereign House 158 West Regent Street Glasgow G2 4RL in data 21 giu 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Sovereign House Sovereign House 158 West Regent Street 158 West Regent Street, Glasgow G2 4RL Scotland a 158 Sovereign House 158 West Regent Street Glasgow G2 4RL in data 20 giu 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Edward Martin come amministratore in data 31 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor, Langstane House 6 Dee Street Aberdeen AB11 6DR Scotland a Sovereign House Sovereign House 158 West Regent Street 158 West Regent Street, Glasgow G2 4RL in data 27 gen 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 15 dic 2015
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Andrew Charles Thorp il 22 mag 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd Aberdeen AB10 1DQ a 3rd Floor, Langstane House 6 Dee Street Aberdeen AB11 6DR in data 19 mag 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy Edward Martin come amministratore in data 29 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUNNINGHAM, Timothy James | Segretario | Blackfriars Road SE1 8NW London 240 England | 259730570001 | |||||||
| SIMONSEN, Erik | Amministratore | 2300 Copenhagen Hannemanns Alle 53 Denmark | Denmark | Danish | 188669650001 | |||||
| THORP, Andrew Charles | Segretario | Stanton Road SW20 8RW London 45 England | 197236250001 | |||||||
| WATSON, Patricia | Segretario | 1 Union Wynd AB10 1SL Aberdeen Union Plaza (2nd Floor) | 160216960001 | |||||||
| WATSON, Patricia | Segretario | 1 Union Wynd AB10 1SL Aberdeen Union Plaza (2nd Floor) | British | 140429740001 | ||||||
| DAVIDSON CHALMERS (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED | Segretario | 12 Hope Street EH2 4DB Edinburgh | 137092310001 | |||||||
| PAULL & WILLIAMSONS | Segretario | Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen | 24280001 | |||||||
| PAULL & WILLIAMSONS LLP | Segretario | 6th Floor 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen Union Plaza | 137701650001 | |||||||
| STRONACHS | Segretario | 34 Albyn Place AB10 1FW Aberdeen Aberdeenshire | 50482710001 | |||||||
| AANDERUD-LARSEN, Tor | Amministratore | Thorsholmen 16 3209 Sanefjord Norway | Norwegian | 133401890001 | ||||||
| BARRON, Paul John, Mr. | Amministratore | Woodlands, Chaple Brae Pitcaple AB51 5HJ Inverurie Aberdeenshire | Scotland | British | 93485570001 | |||||
| BARTHOLOMEW, Iain Douglas, Dr | Amministratore | 7 Woodside Road HP9 1JG Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 192817250001 | |||||
| BAYMAN, Mark | Amministratore | Kinmont Pitcaple AB51 5HJ Inverurie Aberdeenshire | British | 93485450001 | ||||||
| BRATTEBO, Stale | Amministratore | 4056 Tananger Nunsteinveien 23b Norway | Norway | Norwegian | 139549590001 | |||||
| CELENTANO, Raffaele | Amministratore | Kinellar AB21 0RY Aberdeen The Coach House | Scotland | Italian | 141021060001 | |||||
| CHADBOURN, Peter | Amministratore | Dunvegan Aquithie Road AB51 5PD Kemnay Aberdeenshire | Scotland | British | 231962320002 | |||||
| CUNNINGHAM, John Birnie | Amministratore | 9 Crombie Circle Peterculter AB14 0XU Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 111799330001 | |||||
| DUVALL, Stephen Warren | Amministratore | Brawliemuir Farm Johnshaven DD10 0HY Montrose Angus | Scotland | British | 1384050002 | |||||
| DYSJALAND, Per Jarle | Amministratore | Paradisveien 86 4012 Stavanger Paradisveien 86 Norway Norway | Norway | Norwegian | 160181090001 | |||||
| GRUDE, Kjell Enok | Amministratore | N-4352 Kleppe Dynjarvegen 10 Norway | Norway | Norwegian | 148830080001 | |||||
| HATLEM, Per | Amministratore | N-4012 Stavanger Stiftelsegaten 4 Norway | Norway | Norwegian | 166863260001 | |||||
| HATLEM, Per | Amministratore | Stiftelsegaten 4 Norway Stiftelsegaten 4 Norway | Norway | Norwegian | 166863260001 | |||||
| HVISTENDAHL, Frederik | Amministratore | Risnesveien 30 N-4056 Tananger Risnesveien 30 Norway Norway | Norway | Norwegian | 160216580001 | |||||
| KONGSHAUG, Agnar | Amministratore | 4068 8040 Stavanger Apply Sorco As Norway Norway | Norway | Norwegian | 166863670001 | |||||
| KROGH, Lars | Amministratore | 6700 Esbjerg Willemoesgade 2 Denmark | Denmark | Danish | 188668570001 | |||||
| MACKENZIE, William Douglas | Amministratore | Braehead Way Bridge Of Don AB22 8SD Aberdeen 122 Aberdeenshire | Scotland | British | 140430090001 | |||||
| MAGNESEN, Erik | Amministratore | 1 Union Wynd AB10 1SL Aberdeen Union Plaza (2nd Floor) | Norway | Norwegian | 183326760001 | |||||
| MALDE, Ingvar | Amministratore | Robert Scottsgate 6 4021 Stavanger Norway | Norwegian | 133402170001 | ||||||
| MARTIN, Timothy Edward | Amministratore | Sovereign House 158 West Regent Street G2 4RL 158 West Regent Street, Glasgow Sovereign House Scotland | Scotland | British | 79038320004 | |||||
| MCGOWAN, Daniel Joseph | Amministratore | 1 Union Wynd AB10 1SL Aberdeen Union Plaza (2nd Floor) | United Kingdom | British | 127755370001 | |||||
| NAIK, Hemantkumar Sumanlal | Amministratore | 13 Riverside Blackhall AB31 6PS Banchory Kincardineshire | Great Britain | British | 101421640001 | |||||
| REBSDORF-GREGERSEN, Jens | Amministratore | 6700 Esbjerg Willemoesgade 2 Denmark | Denmark | Danish | 188683970001 | |||||
| REIN, Jens Kristian | Amministratore | 1 Union Wynd AB10 1SL Aberdeen Union Plaza (2nd Floor) | Norway | Norwegian | 172691030001 | |||||
| RISE, Arne Magnus | Amministratore | 0250 Oslo Oslo Dronning Muds Gt 11 Norway | Norway | Norwegian | 164765360001 | |||||
| RISE, Arne Magnus | Amministratore | 0484 Oslo Lillogt 5q Norway | Norway | Norwegian | 157636560001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 10 mar 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
RAMBOLL OIL & GAS UK LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creato il 04 dic 2003 Consegnato il 12 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 03 ott 2003 Consegnato il 13 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 17 lug 2003 Consegnato il 31 lug 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the agreement dated 9 july 2003 | |
Brevi particolari Other debts and non-vesting debts. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0