MACDONALD HOTELS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MACDONALD HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC247423 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MACDONALD HOTELS LIMITED?
- Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione
Dove si trova MACDONALD HOTELS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Crutherland House And Spa Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MACDONALD HOTELS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MACDONALD HOTELS PLC | 10 feb 2004 | 10 feb 2004 |
| SKYE LEISURE VENTURES PLC | 08 apr 2003 | 08 apr 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MACDONALD HOTELS LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 24 set 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 24 giu 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 26 set 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MACDONALD HOTELS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 31 mar 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 14 apr 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 31 mar 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per MACDONALD HOTELS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Bilancio consolidato redatto al 26 set 2024 | 42 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Gordon Fraser il 03 giu 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 25 set 2024 al 24 set 2024 | 1 pagine | AA01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Gordon Fraser il 15 mag 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Hugh Gillies il 15 mag 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Iain Gillies il 15 mag 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Donald John Macdonald il 15 mag 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Nomina di Mr James Dickie Davidson come amministratore in data 14 mag 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Miss Marjorie Macdonald come amministratore in data 14 mag 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Stuart Paul Davies come amministratore in data 14 mag 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Modifiche alla garanzia mobiliare SC2474230021 | 103 pagine | 466(Scot) | ||
Modifiche alla garanzia mobiliare SC2474230019 | 103 pagine | 466(Scot) | ||
Modifiche alla garanzia mobiliare SC2474230032 | 104 pagine | 466(Scot) | ||
Modifiche alla garanzia mobiliare SC2474230035 | 104 pagine | 466(Scot) | ||
Modifiche alla garanzia mobiliare SC2474230030 | 103 pagine | 466(Scot) | ||
Iscrizione dell'ipoteca SC2474230034, creata il 21 feb 2025 | 55 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca SC2474230035, creata il 21 feb 2025 | 13 pagine | MR01 | ||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Crutherland House and Spa Strathaven Road East Kilbride G75 0QJ | 1 pagine | AD04 | ||
Bilancio consolidato modificato redatto al 28 set 2023 | 41 pagine | AAMD | ||
Bilancio consolidato redatto al 28 set 2023 | 42 pagine | AA | ||
Soddisfazione dell'onere SC2474230018 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2024 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Soddisfazione dell'onere SC2474230024 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere SC2474230026 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Chi sono gli amministratori di MACDONALD HOTELS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACFARLANE, Stephanie Rose | Segretario | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | 318337980001 | |||||||
| DAVIDSON, James Dickie | Amministratore | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 83786790001 | |||||
| DAVIES, Stuart Paul | Amministratore | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Wales | British | 189892480002 | |||||
| FRASER, Robert Gordon | Amministratore | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 289448940001 | |||||
| GILLIES, Hugh | Amministratore | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | United Kingdom | British | 301475200001 | |||||
| GILLIES, Iain | Amministratore | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 436470002 | |||||
| MACDONALD, Donald John | Amministratore | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 557590001 | |||||
| MACDONALD, Marjorie | Amministratore | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 186033760001 | |||||
| SMITH, Gerard Henry | Amministratore | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | United Kingdom | British | 169821320001 | |||||
| FRASER, Robert Gordon | Segretario | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | 218645150001 | |||||||
| FRASER, Robert Gordon | Segretario | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | 191035270001 | |||||||
| FRASER, Robert Gordon | Segretario | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | 150227120001 | |||||||
| FRASER, Robert Gordon | Segretario | Whiteside House Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate West Lothian | British | 120322350002 | ||||||
| GILMURRAY, Kieran | Segretario | Whiteside House Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate West Lothian | 199214750002 | |||||||
| HEENEY, Caroline | Segretario | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | 309071060001 | |||||||
| MCCREATH, Matthew Brook | Segretario | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | British | 165547750001 | ||||||
| ROSS, Mark | Segretario | 58 Kettilstoun Mains EH49 6SL Linlithgow West Lothian | British | 106803450001 | ||||||
| DM COMPANY SERVICES LIMITED | Segretario nominato | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | 900000320001 | |||||||
| ANDERSON, Bruce Smith | Amministratore | Level 1 Citymark 150 Fountainbridge EH3 9PE Edinburgh Uberior Ventures Limited | Scotland | British | 73849040001 | |||||
| BOTHWELL, Karen Margaret | Amministratore | 68 Ravelston Dykes EH12 6HF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 34800860003 | |||||
| BURNETT, Neil Scott | Amministratore | 5 Cluny Avenue EH10 4RN Edinburgh | British | 93937250001 | ||||||
| CHRISTIE, Scott Sommervaille | Amministratore | Gospatric House Bankhead Road Dalmeny EH30 9TT Edinburgh | Scotland | British | 104262520001 | |||||
| COOK, Robert Barclay | Amministratore | Whiteside House Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate West Lothian | England | British | 172635260001 | |||||
| CUMMING, Andrew John | Amministratore | Suffolk Lane EC4R 0AX London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 46297770002 | |||||
| CUMMINGS, Peter Joseph | Amministratore | Glen View 6 Barloan Crescent G82 2AT Dumbarton Dunbartonshire | Scotland | British | 68241910003 | |||||
| DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony | Amministratore | Cuckoo Meadow Little Shardeloes HP7 0EF Old Amersham Buckinghamshire | England | British | 100598030001 | |||||
| FALLS, Aaron Peter | Amministratore | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 279163090001 | |||||
| GATELEY, Donald Kenneth | Amministratore | Level 1 Citymark 150 Fountainbridge EH3 9PE Edinburgh Uberior Ventures Limited | United Kingdom | British | 104442220001 | |||||
| GRANT, Mary Alexander | Amministratore | Whiteside House Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate West Lothian | United Kingdom | British | 69815990010 | |||||
| GUILE, David Andrew | Amministratore | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | United Kingdom | British | 100133280001 | |||||
| JACKSON, Simon Richard | Amministratore | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian Scotland | United Kingdom | British | 194029260001 | |||||
| MACDONALD, Angus Donald Mackintosh | Amministratore | 18 Hermitage Drive EH10 6BZ Edinburgh | Scotland | British | 43780001 | |||||
| MACDONALD, Ruaridh | Amministratore | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 138199130001 | |||||
| MCBURNIE, Jason | Amministratore | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian Scotland | United Kingdom | British | 202600000001 | |||||
| MCGILL, Michael Scott | Amministratore | 5 Lygon Road EH16 5QD Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 99070570001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MACDONALD HOTELS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Monument/Macdonald Partnership | 06 apr 2016 | Dykedale FK15 0DH Dunblane Cardrona Scotland | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
| Cardrona Charitable Trust | 06 apr 2016 | Dykedale FK15 0DH Dunblane Cardrona Scotland | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0