RSP (HOLDINGS) LIMITED

RSP (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRSP (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC257328
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di RSP (HOLDINGS) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. (42990) / Costruzioni
    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova RSP (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    272 Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RSP (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MACROCOM (857) LIMITED09 ott 200309 ott 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di RSP (HOLDINGS) LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per RSP (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 mag 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 mag 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al01 mag 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per RSP (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2024

    40 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Amey Precision House Mcneil Drive Motherwell ML1 4UR Scotland a 272 Bath Street Glasgow G2 4JR in data 10 lug 2025

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Thomas Solley il 31 gen 2025

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Christopher Thomas Solley come amministratore in data 31 gen 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Martin Timothy Smith come amministratore in data 31 gen 2025

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Epps il 22 nov 2024

    2 pagineCH01

    Nomina di Ms Oytun Altasli Widmer come amministratore in data 26 set 2024

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr John Gerard Connelly come amministratore in data 26 set 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Oytun Altasli Widmer come amministratore in data 26 set 2024

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Epps come amministratore in data 22 nov 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alexandra Jane Hardwicke come amministratore in data 22 nov 2024

    1 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2023

    40 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Neil Andrew Woodburn come amministratore in data 09 feb 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alasdair Campbell come amministratore in data 09 feb 2024

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neeti Mukundrai Anand come amministratore in data 31 dic 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Alexandra Jane Hardwicke come amministratore in data 27 nov 2023

    2 pagineAP01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2022

    40 pagineAA

    Cessazione della carica di Nadiia Kaznacheieva come amministratore in data 06 lug 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Neeti Mukundrai Anand come amministratore in data 27 lug 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neeti Mukundrai Anand come amministratore in data 06 lug 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Oytun Altasli Widmer come amministratore in data 27 lug 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Albany Secretariat Limited come segretario in data 24 mag 2023

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Paul James Hatcher come segretario in data 24 mag 2023

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di RSP (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALBANY SECRETARIAT LIMITED
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    Segretario
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione14325732
    303585870001
    ALTASLI WIDMER, Oytun
    c/o Dif Uk
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    62
    England
    Amministratore
    c/o Dif Uk
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    62
    England
    United KingdomBritishDirector311755640001
    CONNELLY, John Gerard
    c/o Dif Uk
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    62
    England
    Amministratore
    c/o Dif Uk
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    62
    England
    EnglandBritishCompany Director323811250001
    EPPS, David
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Strategy And M&A Director329746670002
    LAING, Frank David
    St Andrew Square
    EH2 2AH Edinburgh
    6
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    St Andrew Square
    EH2 2AH Edinburgh
    6
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritishSenior Analyst256185820002
    PEARMAN, Katherine Anne Louise
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    Amministratore
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant226963920001
    POUPARD, Natalia
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Amministratore
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritishInvestment Director254916130001
    SOLLEY, Christopher Thomas
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Amministratore
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritishDirector166666620001
    WOODBURN, Neil Andrew
    c/o Albany Spc Services Limited
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    c/o Albany Spc Services Limited
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    EnglandBritishDirector137607780003
    HATCHER, Paul James
    3 - 5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    England
    Segretario
    3 - 5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    England
    294214040001
    MACROBERTS - (FIRM)
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Segretario nominato
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    900018030001
    MACROBERTS CORPORATE SERVICES LIMITED
    60 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Capella Building (Tenth Floor)
    Scotland
    Segretario
    60 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Capella Building (Tenth Floor)
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC177032
    130204580001
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Segretario
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione5615519
    109588620001
    ALTASLI WIDMER, Oytun
    62 Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    Dif Uk
    England
    Amministratore
    62 Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    Dif Uk
    England
    United KingdomBritishDirector311755640001
    ANAND, Neeti Mukundrai
    62 Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    Dif Uk
    England
    Amministratore
    62 Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    Dif Uk
    England
    EnglandBritishDirector250186840001
    ANAND, Neeti Mukundrai
    Level 4
    2-4 Idol Lane
    EC3R 5DD London
    Dif Uk
    United Kingdom
    Amministratore
    Level 4
    2-4 Idol Lane
    EC3R 5DD London
    Dif Uk
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector250186840001
    ANAND, Neeti Mukundrai
    Level 4
    2-4 Idol Lane
    EC3R 5DD London
    Dif Uk
    United Kingdom
    Amministratore
    Level 4
    2-4 Idol Lane
    EC3R 5DD London
    Dif Uk
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector250186840001
    ANDERSON, Derek Orr
    9 The Spinneys
    KY11 9SL Dalgety Bay
    Fife
    Amministratore
    9 The Spinneys
    KY11 9SL Dalgety Bay
    Fife
    ScotlandBritishBanker161345590001
    BRADBURY, Richard George
    Beech Cottage Beech Lane
    WA6 6LP Norley
    Cheshire
    Amministratore
    Beech Cottage Beech Lane
    WA6 6LP Norley
    Cheshire
    BritishGroup Commercial Director42234330002
    BREE, Rhona Macdonald
    Flat 3/2
    64 Miller Street
    G1 1DT Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Flat 3/2
    64 Miller Street
    G1 1DT Glasgow
    Lanarkshire
    BritishBanker99563640001
    CAMPBELL, Alasdair
    Bartholemew Close
    EC1A 7HH London
    1
    England
    England
    Amministratore
    Bartholemew Close
    EC1A 7HH London
    1
    England
    England
    ScotlandBritishInvestment Executive215915630001
    CHESTER, Jonathan Roger
    2 Giffard Close
    ST19 9HD Brewood
    Stafford
    Amministratore
    2 Giffard Close
    ST19 9HD Brewood
    Stafford
    BritishFinance Director94576750001
    CONNELLY, John Gerard
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    Amministratore
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    ScotlandBritishHead Of Energy, Environment & Place And Director152971000001
    CONNELLY, John Gerard
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Amministratore
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    ScotlandBritishHead Of Investment Management152971000001
    COOPER, Phillip John
    c/o C/O Hsbc Specialist Fund Management Limited
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Hsbc Specialist Fund Management Limited
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector116775310001
    COPPIN, Andrew John
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    United Kingdom
    Amministratore
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    United Kingdom
    United KingdomBritishCommercial Director130949770001
    COTTRELL, Keith
    12 Brightlingsea Place
    E14 8DB London
    Amministratore
    12 Brightlingsea Place
    E14 8DB London
    BritishInvestment Manager88691090001
    FALERO, Louis Javier
    Level 4
    2 - 4 Idol Lane
    EC3R 5DD London
    Dif Uk
    United Kingdom
    Amministratore
    Level 4
    2 - 4 Idol Lane
    EC3R 5DD London
    Dif Uk
    United Kingdom
    EnglandBritishFund Manager301858300001
    FALERO, Louis Javier
    c/o C/O Dif
    Idol Lane
    EC3R 5DD London
    2-4
    England
    Amministratore
    c/o C/O Dif
    Idol Lane
    EC3R 5DD London
    2-4
    England
    EnglandBritishFund Manager301858300001
    FARLEY, Graham
    9 Manor Close
    Hinstock
    TF9 2TZ Market Drayton
    Salop
    Amministratore
    9 Manor Close
    Hinstock
    TF9 2TZ Market Drayton
    Salop
    United KingdomBritishDirector183764380001
    FORSYTH, Peter, Dr
    Long Kensome, South Green
    Kirtlington
    OX5 3HJ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Long Kensome, South Green
    Kirtlington
    OX5 3HJ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector207405700001
    GHAFOOR, Asif
    Floor
    Chancery Exchange 10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    4th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Chancery Exchange 10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    4th
    United Kingdom
    United KingdomBritishSenior Director277343840001
    GILLESPIE, Kenneth William
    7 Shaws Crescent
    EH26 0RE Milton Bridge
    Midlothian
    Amministratore
    7 Shaws Crescent
    EH26 0RE Milton Bridge
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector105139700001
    GILLESPIE, Kenneth William
    7 Shaws Crescent
    EH26 0RE Milton Bridge
    Midlothian
    Amministratore
    7 Shaws Crescent
    EH26 0RE Milton Bridge
    Midlothian
    ScotlandBritishBanker105139700001
    GRANT, Stewart Chalmers
    The Gherkin
    30 St. Mary Axe
    EC3A 8BF London
    Dif Uk Management Limited
    England
    Amministratore
    The Gherkin
    30 St. Mary Axe
    EC3A 8BF London
    Dif Uk Management Limited
    England
    United KingdomBritishAsset Manager206362380001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RSP (HOLDINGS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    1 Bread Street
    EC4M 9HH London
    Bow Bells House
    England
    England
    06 apr 2016
    1 Bread Street
    EC4M 9HH London
    Bow Bells House
    England
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione6632304
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    3 - 5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    England
    06 apr 2016
    3 - 5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4738493
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    One Bartholemew Close
    Barts Square
    EC1A 7BL London
    Level 7
    United Kingdom
    06 apr 2016
    One Bartholemew Close
    Barts Square
    EC1A 7BL London
    Level 7
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione6555131
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0