TAYDALE (GRANTON) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TAYDALE (GRANTON) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC258109 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
- Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
Dove si trova TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Argyll Court The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Scotland Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MITRESHELF 353 LIMITED | 23 ott 2003 | 23 ott 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 nov 2016 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 10 in pieno | 5 pagine | MR04 | ||||||||||
Stato del capitale al 07 lug 2016
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 30 apr 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Keith Richard Douglas il 22 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 22 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Henry Sharp il 22 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 22 ott 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Regency House Crossgates Road Halbeath Dunfermline Fife KY11 7EG a Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT in data 23 ott 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 31 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Giles Sharp come amministratore in data 23 gen 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Fitzsimmons come amministratore in data 12 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Segretario | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | British | 150144100001 | ||||||||||
| DOUGLAS, Keith Richard | Amministratore | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 91229410003 | |||||||||
| LEWIS, Colin Edward | Amministratore | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||||||
| SHARP, Giles Henry | Amministratore | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Segretario | New Bond Street W1S 1SB London 80 United Kingdom | British | 175715660001 | ||||||||||
| CARR, Peter Anthony | Segretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||||||
| DE FEO, Caterina | Segretario | 42 The Crescent Hampton In Arden B92 0BP Solihull West Midlands | British | 58246930001 | ||||||||||
| HASTINGS, Jonathan Philip | Segretario | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||||||
| JORDAN, James John | Segretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||||||
| BISHOPS | Segretario nominato | 2 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | 900025710001 | |||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Segretario | St Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 |
| 119967690001 | ||||||||||
| ANDERSON, Alexander | Amministratore | 34 Ledcameroch Gardens FK15 0GZ Dunblane Perthshire | Scotland | British | 114144470001 | |||||||||
| ARMSTRONG, Karen Jean | Amministratore | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 137938400001 | |||||||||
| BROWN, Simon Christopher | Amministratore | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 113724050001 | |||||||||
| BURNS, William Rae | Amministratore | Barnton Grove Barnton EH4 6EJ Edinburgh 24 | United Kingdom | British | 132773610001 | |||||||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Amministratore | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||||||
| COPSTICK, Thomas Crawford | Amministratore | B Glasgow Road Ralston PA1 3JR Paisley 227 Renfrewshire Scotland | British | 129081370001 | ||||||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||||||
| FOWLER, Steven | Amministratore | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 101839920001 | |||||||||
| GAFFNEY, David | Amministratore | Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Regency House Fife | Scotland | British | 84605410002 | |||||||||
| HALDANE, Kenneth Douglas | Amministratore | 64 Victoria Road PA2 9PT Paisley Renfrewshire | United Kingdom | British | 94477860001 | |||||||||
| KENNEDY, David Samuel | Amministratore | 1 Glebe Gardens EH12 7SG Edinburgh | British | 93176930001 | ||||||||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Amministratore | Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Regency House Fife | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Amministratore | 35 Cardowan Road Stepps G33 6HJ Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||||||
| KNIGHT, David Jonathan | Amministratore | 24 Margaret Rose Crescent EH10 7EZ Edinburgh | United Kingdom | British | 190746580001 | |||||||||
| MACLEOD, Angus Iain | Amministratore | St Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | Scotland | British | 57667380001 | |||||||||
| MACLEOD, Joanne May | Amministratore | Silvermills EH3 5BF Edinburgh 23/3 | British | 118869790002 | ||||||||||
| MCGOWAN, Jim | Amministratore | 66 Mulben Crescent G53 7EH Glasgow Lanarkshire | British | 123746950001 | ||||||||||
| MITCHELL, David Murray | Amministratore | 9 Kirklands Drive Newton Mearns G77 5FF Glasgow | British | 91206920001 | ||||||||||
| MORAN, Paul Anthony | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 96935230001 | |||||||||
| MORTIMORE, Jon William | Amministratore | Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Regency House Fife | United Kingdom | British | 207729000002 | |||||||||
| PHILLIPS, Richard James | Amministratore | 5 Brighouse Park Court Cramond EH4 6QF Edinburgh | British | 118057520001 | ||||||||||
| YARDLEY, Norman | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 153904770001 | |||||||||
| MITRESHELF DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 2 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | 900025700001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TAYDALE (GRANTON) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant Homes Group Limited | 06 apr 2016 | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TAYDALE (GRANTON) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creato il 02 feb 2010 Consegnato il 15 feb 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Obligations contained in the missives | |
Brevi particolari Plot 27 granton harbour edinburgh MID56170. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 02 feb 2010 Consegnato il 13 feb 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Plot 27 granton harbour edinburgh MID56170. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession to residential security agreement | Creato il 29 gen 2010 Consegnato il 05 feb 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari First legal mortgage over all estates or interests in any freehold or leasehold property owned by it, all plant and machinery etc-see form for further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 29 gen 2010 Consegnato il 05 feb 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Standard security | Creato il 09 feb 2004 Consegnato il 19 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Plots 26 & 27 granton harbour, edinburgh MID56170. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 09 feb 2004 Consegnato il 19 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Plots 26 & 27 at granton harbour, edinburgh MID56170. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 09 feb 2004 Consegnato il 17 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Part of two areas of ground forming plots 26 & 27, granton harbour, edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 09 feb 2004 Consegnato il 12 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Obligations set out in the missives | |
Brevi particolari Plots 26 & 27 granton harbpur, edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 23 gen 2004 Consegnato il 29 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creato il 23 gen 2004 Consegnato il 29 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0