EAC LANGUAGE CENTRES (UK) LIMITED
Panoramica
Nome della società | EAC LANGUAGE CENTRES (UK) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC262077 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EAC LANGUAGE CENTRES (UK) LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova EAC LANGUAGE CENTRES (UK) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | British Study Centres Limited, 62-66 George Street EH2 2LR Edinburgh Scotland |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EAC LANGUAGE CENTRES (UK) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ROADCYCLE LIMITED | 25 mar 2004 | 25 mar 2004 |
EAC LANGUAGE CENTRES (UK) LIMITED | 26 gen 2004 | 26 gen 2004 |
ALLOWJEWEL LIMITED | 19 gen 2004 | 19 gen 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EAC LANGUAGE CENTRES (UK) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 ago 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per EAC LANGUAGE CENTRES (UK) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Christine Salisbury come amministratore in data 27 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Christine Salisbury come segretario in data 27 nov 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Jennifer Elaine Keen come amministratore in data 27 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Gemma Lynch come amministratore in data 27 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Nicolas Paul Alexandrou come amministratore in data 27 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mrs Christine Salisbury come segretario in data 18 ott 2019 | 2 pagine | AP03 | ||
Nomina di Mrs Christine Salisbury come amministratore in data 18 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Simon Thomas Counsell come amministratore in data 18 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Simon Thomas Counsell come segretario in data 18 ott 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 ago 2019 al 31 ott 2019 | 1 pagine | AA01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Miss Jennifer Elaine Kenn il 05 giu 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Nomina di Miss Jennifer Elaine Kenn come amministratore in data 05 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Nicolas Paul Alexandrou come amministratore in data 05 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Karen Mary Smith-Watson come segretario in data 05 giu 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Mark Leonard Bush come amministratore in data 05 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Karen Mary Smith-Watson come amministratore in data 05 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Simon Thomas Counsell come segretario in data 05 giu 2019 | 2 pagine | AP03 | ||
Nomina di Mr Simon Thomas Counsell come amministratore in data 05 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio abbreviato redatto al 31 ago 2018, non revisionato | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di EAC LANGUAGE CENTRES (UK) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNNEY, Michael | Amministratore | George Street EH2 2LR Edinburgh British Study Centres Limited, 62-66 Scotland | Ireland | Irish | Accountant | 209610440001 | ||||
ALEXANDROU, Nick | Segretario | c/o Darren Tierney George Street EH2 2LR Edinburgh 62-66 Scotland | 222943850001 | |||||||
COUNSELL, Simon Thomas | Segretario | George Street EH2 2LR Edinburgh British Study Centres Limited, 62-66 Scotland | 259242210001 | |||||||
FISHER, Andrew John | Segretario | 10 Johnsburn Park EH14 7NA Balerno Midlothian | British | Director | 65820970002 | |||||
SALISBURY, Christine | Segretario | George Street EH2 2LR Edinburgh British Study Centres Limited, 62-66 Scotland | 263940360001 | |||||||
SMITH-WATSON, Karen Mary | Segretario | Cromwell Road BN3 3ER Hove 47 East Sussex England | 241361370001 | |||||||
TIERNEY, Darren | Segretario | c/o Darren Tierney George Street EH2 2LR Edinburgh 62-66 Scotland | 209610420001 | |||||||
WALTER, Joyce | Segretario | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd United Kingdom | British | 76169540002 | ||||||
OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Segretario nominato | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
ALEXANDROU, Nicolas Paul | Amministratore | George Street EH2 2LR Edinburgh British Study Centres Limited, 62-66 Scotland | England | British | Director | 240333800001 | ||||
ANDREWS, David | Amministratore | c/o Darren Tierney George Street EH2 2LR Edinburgh 62-66 Scotland | Ireland | Irish | Accountant | 209610460001 | ||||
ARMSTRONG, Graeme William | Amministratore | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 154772420002 | ||||
BAINBRIDGE, Richard Charles | Amministratore | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 167483780001 | ||||
BAINBRIDGE, Richard Charles | Amministratore | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 167483780001 | ||||
BURT, Jayne | Amministratore | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 130725790002 | ||||
BUSH, Mark Leonard | Amministratore | George Street EH2 2LR Edinburgh British Study Centres Limited, 62-66 Scotland | England | British | Company Director | 138053080004 | ||||
COUNSELL, Simon Thomas | Amministratore | George Street EH2 2LR Edinburgh British Study Centres Limited, 62-66 Scotland | United Kingdom | Scottish | Director | 202874440001 | ||||
DICK, Fergus | Amministratore | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 170557360001 | ||||
FINLAY, Ian Stuart | Amministratore | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd United Kingdom | England | British | Company Director | 94385390003 | ||||
FISHER, Andrew John | Amministratore | 10 Johnsburn Park EH14 7NA Balerno Midlothian | Scotland | British | Director | 65820970002 | ||||
FROGGATT, Martin James | Amministratore | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd United Kingdom | England | British | Company Director | 174994170002 | ||||
HAWKES, Paul Christopher | Amministratore | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd United Kingdom | England | British | Company Director | 130557730001 | ||||
JONES, Brendan Derek Lee | Amministratore | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd | United Kingdom | British | Managing Director | 185317750001 | ||||
KEEN, Jennifer Elaine | Amministratore | George Street EH2 2LR Edinburgh British Study Centres Limited, 62-66 Scotland | England | Canadian | Director | 142691330002 | ||||
LYNCH, Gemma | Amministratore | George Street EH2 2LR Edinburgh British Study Centres Limited, 62-66 Scotland | Ireland | Irish | Company Director | 302403550001 | ||||
MEE, Darren | Amministratore | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 197107770001 | ||||
MORGAN, Richard John | Amministratore | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd United Kingdom | British | Director | 40185320005 | |||||
O' LEARY, Neil | Amministratore | c/o Darren Tierney George Street EH2 2LR Edinburgh 62-66 Scotland | Ireland | Irish | Accountant | 203048220001 | ||||
OSMAN, Rebecca Louise | Amministratore | Floor Elder House, Elder Street Multrees Walk EH1 3DX Edinburgh 3rd United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 180232530001 | ||||
SALISBURY, Christine | Amministratore | George Street EH2 2LR Edinburgh British Study Centres Limited, 62-66 Scotland | United Kingdom | British | Director | 263936820001 | ||||
SMITH-WATSON, Karen Mary | Amministratore | George Street EH2 2LR Edinburgh British Study Centres Limited, 62-66 Scotland | England | Irish | Accountant | 193627030001 | ||||
WATSON, Karen Mary | Amministratore | 45 Frederick Street Edinburgh EH2 1EP | England | Irish | Company Director | 74073940003 | ||||
YOUNG, Stuart Samuel | Amministratore | 18 Swanston Place EH10 7DD Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Director | 66184670001 | ||||
JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Amministratore delegato nominato | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EAC LANGUAGE CENTRES (UK) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Experience English Limited | 14 lug 2017 | Cromwell Road BN3 3ER Hove 47 East Sussex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Mr Michael Tunney | 25 mag 2016 | c/o DARREN TIERNEY George Street EH2 2LR Edinburgh 62-66 Scotland | Sì | ||||||||||
Nazionalità: Irish Paese di residenza: Ireland | |||||||||||||
Natura del controllo
|
EAC LANGUAGE CENTRES (UK) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Standard security | Creato il 31 ott 2008 Consegnato il 05 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 20/2 easter dalry rigg, edinburgh MID19089. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 03 dic 2007 Consegnato il 05 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 5 lauriston park, edinburgh MID13625. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 26 gen 2005 Consegnato il 04 feb 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 30 nov 2004 Consegnato il 09 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0