SCARBOROUGH VENTURES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SCARBOROUGH VENTURES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC262480 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SCARBOROUGH VENTURES LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova SCARBOROUGH VENTURES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SCARBOROUGH VENTURES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SDG CALEDONIA HOLDINGS LIMITED | 27 gen 2004 | 27 gen 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SCARBOROUGH VENTURES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 28 feb 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per SCARBOROUGH VENTURES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato) | 10 pagine | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ Scotland a C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD in data 24 feb 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Charles Mccabe come amministratore in data 15 gen 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 13 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 14 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Shepherd and Wedderburn, 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL Scotland a C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ in data 01 set 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Esplanade Director Limited come amministratore in data 21 ago 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Esplanade Director Limited come amministratore in data 15 ago 2020 | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Esplanade Director Limited come amministratore in data 15 ago 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Charles Mccabe come amministratore in data 21 ago 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Charles Mccabe il 26 nov 2019 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 28 feb 2019 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Lomond Court Castle Business Park Stirling FK9 4TU a C/O Shepherd and Wedderburn, 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL in data 04 lug 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 28 feb 2018 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Kevin Charles Mccabe come amministratore in data 30 lug 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Scarborough Group Limited come persona con controllo significativo il 28 feb 2017 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Scarborough Group Holdings Limited come persona con controllo significativo il 28 feb 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Nomina di Mr Jeremy John Tutton come amministratore in data 01 set 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SCARBOROUGH VENTURES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire United Kingdom |
| 123430250001 | ||||||||||
| MCCABE, Scott Richard | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | 151895310001 | |||||||||
| TUTTON, Jeremy John | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | United Kingdom | British | 113787520002 | |||||||||
| BROOK, Susan Margaret | Segretario | 16 Bradley Lane Rufforth YO23 3QJ York North Yorkshire | British | 72328070001 | ||||||||||
| ELDER, Christopher James | Segretario | 190/8 Bruntsfield Place EH10 4DF Edinburgh Midlothian | British | 100964190001 | ||||||||||
| TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 93 George Street EH2 3ES Edinburgh | 90707230001 | |||||||||||
| BROWN, Stewart David | Amministratore | 6 Moat Place EH14 1NY Edinburgh Midlothian | British | 77509780001 | ||||||||||
| BURNLEY, John Lewis | Amministratore | Lantern Cottage Weeton Lane, Weeton LS17 0AN Leeds | England | British | 35543830001 | |||||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Amministratore | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | 1267050001 | |||||||||
| ELDER, Christopher James | Amministratore | 190/8 Bruntsfield Place EH10 4DF Edinburgh Midlothian | British | 100964190001 | ||||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Amministratore | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | 56953000002 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | England | British | 109250000012 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Amministratore | 1000 Brussels Franklin Roosevelt 135 Belgium | British | 109250000007 | ||||||||||
| MCCABE, Simon Charles | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | 154915110001 | |||||||||
| TANDY, Didier Michel | Amministratore | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | 69909950001 | |||||||||
| ESPLANADE DIRECTOR LIMITED | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England |
| 123430390001 | ||||||||||
| ESPLANADE DIRECTOR LIMITED | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire United Kingdom |
| 123430390001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SCARBOROUGH VENTURES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarborough Group Limited | 28 feb 2017 | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Scarborough Group Holdings Limited | 06 apr 2016 | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SCARBOROUGH VENTURES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creato il 06 giu 2011 Consegnato il 14 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 20 high street paisley REN112505. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 06 giu 2011 Consegnato il 14 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 20 high street paisleyren 112505. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation of rents | Creato il 03 giu 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Whole right, title and interest in and to the assigned rights (over 20 high street, paisley REN112505). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation of rents | Creato il 03 giu 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Whole right, title and interest in and to the assigned rights (over 20 high street, paisley REN112505). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security interest agreement | Creato il 23 mag 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Security interest in the collateral-see form fo further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security interest agreement | Creato il 23 mag 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Security interest in the collateral-see form fo further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 mag 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Debenture | Creato il 20 mag 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creato il 20 mag 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creato il 20 mag 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Assignment in security | Creato il 26 giu 2009 Consegnato il 15 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Payment of monies in terms of the sheffield assignment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 04 feb 2008 Consegnato il 08 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 20 high street, paisley REN112505. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation of rents | Creato il 25 gen 2008 Consegnato il 26 gen 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The rent in terms of the lease over 20 high street, paisley REN112505. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 28 gen 2005 Consegnato il 08 feb 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over all the freehold property known as land to the north east side of tilton road, small heath (title number WM462753); fixed and floating charges over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 26 apr 2004 Consegnato il 30 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Legal charge containing a floating charge | Creato il 26 apr 2004 Consegnato il 30 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over all the freehold property known as 130/136 deansgate and 101/103 bridge street, manchester ; fixed and floating charges over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
SCARBOROUGH VENTURES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0