HYMORE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHYMORE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC271129
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HYMORE LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova HYMORE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    ERNST & YOUNG LLP
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HYMORE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KENMORE HYDON ONE LIMITED04 mar 200504 mar 2005
    DMWS 683 LIMITED26 lug 200426 lug 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di HYMORE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per HYMORE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio dall'amministrazione allo scioglimento

    6 pagine2.26B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    6 pagine2.20B(Scot)

    Avviso di proroga del periodo di amministrazione

    2 pagine2.22B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    6 pagine2.20B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    6 pagine2.20B(Scot)

    Avviso di proroga del periodo di amministrazione

    1 pagine2.22B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    6 pagine2.20B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    6 pagine2.20B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    6 pagine2.20B(Scot)

    Avviso di proroga del periodo di amministrazione

    1 pagine2.22B(Scot)

    Stato patrimoniale con modulo allegato 2.13B(Scot)

    16 pagine2.15B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    6 pagine2.20B(Scot)

    Proposta dell'amministratore

    21 pagine2.16B(Scot)

    Nomina di un amministratore

    3 pagine2.11B(Scot)

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Agreement 08/02/08
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Sub-divide 08/02/08
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    2 pagine122

    Chi sono gli amministratori di HYMORE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Anne Elizabeth
    Ramsay Crescent
    Mayfield
    EH22 5RA Dalkeith
    13
    Midlothian
    Segretario
    Ramsay Crescent
    Mayfield
    EH22 5RA Dalkeith
    13
    Midlothian
    British74781620001
    MEGAN, Michael Francis
    Highlands
    RG14 6NZ Newbury
    8
    Berkshire
    Amministratore
    Highlands
    RG14 6NZ Newbury
    8
    Berkshire
    EnglandIrishAccountant46067860003
    REID, Andrew Richard
    4 Summerfield Road
    Cumbernauld
    G67 4PA Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    4 Summerfield Road
    Cumbernauld
    G67 4PA Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector145630001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    THOMSON, William George Ritchie
    The Old House Of Orchill
    FK15 9LF Braco
    Perthshire
    Amministratore
    The Old House Of Orchill
    FK15 9LF Braco
    Perthshire
    ScotlandBritishChartered Accountant72331280002
    WADSWORTH, Timothy Murray
    Dowlands House
    Rousdon
    DT7 3XP Lyme Regis
    Amministratore
    Dowlands House
    Rousdon
    DT7 3XP Lyme Regis
    United KingdomBritishSurveyor34037140009
    WILKINSON, Charles George
    Gilbury
    30 Riverside Road West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    Amministratore
    Gilbury
    30 Riverside Road West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritishChartered Surveyor47095110003
    DM DIRECTOR LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore delegato nominato
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900020020001

    HYMORE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 04 ott 2006
    Consegnato il 18 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tonedale mill, wellington, somerset ST1516 ST200245 ST247441 and ST199157 includes fixed and floating charges.
    Persone aventi diritto
    • Lochay Investments Limited
    Transazioni
    • 18 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 04 ott 2006
    Consegnato il 18 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tonedale mill, wellington, somerset ST1516 ST200245 ST247441 and ST199157 includes fixed and floating charges.
    Persone aventi diritto
    • Kenmore Investments Limited
    Transazioni
    • 18 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 04 ott 2006
    Consegnato il 05 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tonedale mill, wellington, somerset ST1516 ST200245 ST247441 ST199157.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 03 ott 2006
    Consegnato il 10 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 ott 2006Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Legal charge
    Creato il 07 apr 2005
    Consegnato il 21 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    By way of a legal mortgage over freehold land at and buildings known as 73 north street, crewkerne WS3601 land on the north east side of north street, crewkerne, somerset ws 28865 all that land and building known as old brewery barn north street, crewkerne WS3601 and ws 28865.
    Persone aventi diritto
    • Lochay Investments Limited
    Transazioni
    • 21 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 07 apr 2005
    Consegnato il 21 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    By way of a legal mortgage over freehold land at and buildings known as 73 north street, crewkerne WS3601 land on the north east side of north street, crewkerne, somerset ws 28865 all that land and building known as old brewery barn north street, crewkerne WS3601 and ws 28865.
    Persone aventi diritto
    • Kenmore Investments Limited
    Transazioni
    • 21 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 2005
    Consegnato il 12 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land on the north east side of north street, crewkerne, somerset (title number WS28865) and old brewery barn, north street, crewkerne, somerset.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Legal charge
    Creato il 11 mar 2005
    Consegnato il 01 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over freehold land and buildings at 73 north street, crawkerne WS3601.
    Persone aventi diritto
    • Lochay Investments Limited
    Transazioni
    • 01 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 11 mar 2005
    Consegnato il 01 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over freehold land and buildings at 73 north street, crawkerne WS3601.
    Persone aventi diritto
    • Kenmore Investments Limited
    Transazioni
    • 01 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 11 mar 2005
    Consegnato il 21 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 mar 2005Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 15 apr 2005Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Legal charge
    Creato il 11 mar 2005
    Consegnato il 21 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The freehold property known as 73 north street, crewkerne, somerset (title number WS3601).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (410)

    HYMORE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 nov 2012Fine dell'amministrazione
    12 dic 2008Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Thomas Merchant Burton
    Ernst & Young
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praticante
    Ernst & Young
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praticante
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0