QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC273554 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 28 feb 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato) | 8 pagine | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ Scotland a C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD in data 24 feb 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Scott Richard Mccabe come amministratore in data 15 gen 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Charles Mccabe come amministratore in data 15 gen 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Shepherd and Wedderburn, 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL Scotland a C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ in data 01 set 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jeremy John Tutton come amministratore in data 21 ago 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Esplanade Director Limited come amministratore in data 21 ago 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Charles Mccabe come amministratore in data 21 ago 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Charles Mccabe il 26 nov 2019 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 28 feb 2019 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Lomond Court Castle Business Park Stirling FK9 4TU a C/O Shepherd and Wedderburn, 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL in data 04 lug 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 28 feb 2018 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 28 feb 2017 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Kevin Charles Mccabe come amministratore in data 30 lug 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AC93 | ||||||||||
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria | 7 pagine | 4.26(Scot) | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire England |
| 123430250001 | ||||||||||
| MCCABE, Scott Richard | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | England | British | 151895310001 | |||||||||
| TUTTON, Jeremy John | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | United Kingdom | British | 113787520002 | |||||||||
| CAPPER, Simon | Segretario | 3 The Gowans Sutton On The Forest YO61 1DL York North Yorkshire | British | 118147580001 | ||||||||||
| MCCABE, Jo Anne | Segretario | The Lodge 1 Green Lane Lebberston YO11 3PF Scarborough North Yorkshire | British | 66513250002 | ||||||||||
| MCCABE, Sandra | Segretario | 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough The White House North Yorkshire | British | 920260005 | ||||||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Segretario nominato | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||||||
| BURNLEY, John Lewis | Amministratore | Lantern Cottage Weeton Lane, Weeton LS17 0AN Leeds | England | British | 35543830001 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | England | British | 109250000012 | |||||||||
| MCCABE, Scott Richard | Amministratore | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 67294400005 | ||||||||||
| MCCABE, Simon Charles | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | 154915110001 | |||||||||
| MCCABE, Simon Charles | Amministratore | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | British | 103888320002 | |||||||||
| STACEY, John Marcus William | Amministratore | 245 Windsor Road Carlton In Lindrick S81 9DH Worksop Nottinghamshire | England | British | 112379430001 | |||||||||
| ESPLANADE DIRECTOR LIMITED | Amministratore | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire England |
| 123430390001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarborough Property Developments Limited | 06 apr 2016 | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 01 ago 2014 Consegnato il 09 ago 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 39 mark road, hemel hempstead, HD252081. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 30 lug 2014 Consegnato il 14 ago 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 23 gen 2014 Consegnato il 03 feb 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Innovation house, 39 mark road, maylands avenue hemel hempstead HD252081. Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 mag 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Debenture | Creato il 20 mag 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creato il 20 mag 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creato il 20 mag 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 mar 2009 Consegnato il 03 apr 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over freehold property known as 39 mark road, hemel hempstead HD252081 and a floating charge over all unattached plant, machinery, chattels and goods. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 22 mag 2006 Consegnato il 03 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the freehold property known as innovation house, 39 mark street, hemel hempstead, hertfordshire hd 252081. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 10 mag 2006 Consegnato il 12 mag 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Subjects at whitemyres avenue, aberdeen abn 80786. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rental assignation | Creato il 02 mag 2006 Consegnato il 12 mag 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The rent payable under the leases of the property at whitemyres avenue, aberdeen abn 80786. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 30 dic 2005 Consegnato il 06 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The lombard centre, kirkhill industrial estate, aberdeen ABN2186. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rental assigantion | Creato il 21 dic 2005 Consegnato il 06 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Rents due under the leases of the lombard centre, kirkhill industrial estate, aberdeen ABN2186. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 16 dic 2005 Consegnato il 20 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Ground floor shop premises, 11 high street, penicuik. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rental assignation | Creato il 14 dic 2005 Consegnato il 20 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The rent and other sums payable by the tenants under their lease of the ground floor premises 11 high street, penicuik. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 22 nov 2005 Consegnato il 28 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 7 melville terrace, stirling STG316. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rental assignation | Creato il 18 nov 2005 Consegnato il 28 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Rents payable under leases of 7 melville terrace, stirling STG316. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 02 mag 2005 Consegnato il 10 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The ground floor and basement shop premises known as 17 church hill place, edinburgh, in the county of midlothian which subjects form part of the subjects known as 13, 15 and 17 church hill place, edinburgh mid 30547. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 02 feb 2005 Consegnato il 11 feb 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 3-19 whistleberry industrial estate, hamilton. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 26 gen 2005 Consegnato il 09 feb 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
QUOIN PROPERTY COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
| |||||||||||||
| 2 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0