WILBURN HOMES SOUTHERN LIMITED

WILBURN HOMES SOUTHERN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWILBURN HOMES SOUTHERN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC277645
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WILBURN HOMES SOUTHERN LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova WILBURN HOMES SOUTHERN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    19 Rutland Square
    Edinburgh
    EH1 2BB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WILBURN HOMES SOUTHERN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WILBURN HOMES (SOUTHERN) LIMITED21 dic 200421 dic 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di WILBURN HOMES SOUTHERN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WILBURN HOMES SOUTHERN LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WILBURN HOMES SOUTHERN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Darren Richard Martin come amministratore in data 29 giu 2012

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineAC93

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 gen 2012

    Stato del capitale al 17 gen 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    accounts-with-accounts-type-

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    accounts-with-accounts-type-

    5 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Burns il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Various charges and agreements
    RES13

    legacy

    3 pagineMG04s

    legacy

    5 pagineMG01s

    legacy

    3 pagine363a

    accounts-with-accounts-type-

    6 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    14 pagineAA

    legacy

    2 pagine419b(Scot)

    legacy

    2 pagine419a(Scot)

    legacy

    2 pagine419a(Scot)

    Chi sono gli amministratori di WILBURN HOMES SOUTHERN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURNS, Keith
    Flat 11, 3 Roseburn Maltings
    EH12 5LY Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    Flat 11, 3 Roseburn Maltings
    EH12 5LY Edinburgh
    Midlothian
    British107778410001
    BURNS, Patrick
    5 Succoth Gardens
    EH12 6BR Edinburgh
    Amministratore
    5 Succoth Gardens
    EH12 6BR Edinburgh
    ScotlandBritish53240380001
    MURRAY, Sheena
    135 Baberton Mains Drive
    EH14 3EA Edinburgh
    Segretario
    135 Baberton Mains Drive
    EH14 3EA Edinburgh
    British93608740001
    HOGG JOHNSTON SECRETARIES LTD.
    2 Bellevue Street
    EH7 4BY Edinburgh
    Segretario
    2 Bellevue Street
    EH7 4BY Edinburgh
    98237760001
    MARTIN, Darren Richard
    6 Henderson Terrace
    EH11 2JZ Edinburgh
    Amministratore
    6 Henderson Terrace
    EH11 2JZ Edinburgh
    United KingdomBritish103379290002
    ROGERSON, Stewart
    Tile House
    Bolton Percy
    YO23 7AB York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Tile House
    Bolton Percy
    YO23 7AB York
    North Yorkshire
    British108935120001
    SMITH, Norman Alan
    Auchengrange Steading
    Balltrees Road
    PA12 4JS Lochwinnoch
    Amministratore
    Auchengrange Steading
    Balltrees Road
    PA12 4JS Lochwinnoch
    ScotlandBritish156114890001
    HOGG JOHNSTON DIRECTORS LTD.
    2 Bellevue Street
    EH7 4BY Edinburgh
    Amministratore
    2 Bellevue Street
    EH7 4BY Edinburgh
    98237750001

    WILBURN HOMES SOUTHERN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 08 ott 2009
    Consegnato il 16 ott 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Standard security
    Creato il 05 mar 2007
    Consegnato il 12 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground at main street, bridge of earn, county of perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 10 nov 2005
    Consegnato il 21 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond dated 31 october 2005
    Brevi particolari
    Area of ground at baldow park, kincraig lying on the south east side of the kincraig-aviemore road in the county of inverness (title number inv 12866).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 06 giu 2005
    Consegnato il 08 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of a personal bond dated 30 may 2005
    Brevi particolari
    The subjects known as unit 6, portland square, kilmarnock (title number AYR31296).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 03 giu 2005
    Consegnato il 08 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due in terms of a personal bond dated 30 may 2005
    Brevi particolari
    The subjects units 3 & 4, coatbridge retail park, locks street, coatbridge (title number LAN140963).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 16 mag 2005
    Consegnato il 27 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due in terms of clause 2.7 of missives
    Brevi particolari
    Area of ground at strothers lane, inverness.
    Persone aventi diritto
    • Cairn Housing Association Limited
    Transazioni
    • 27 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 14 ott 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    Standard security
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 06 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    That area or piece of ground lying on the north west side of strothers lane, inverness extending to 1325.1 square metres or thereby inv 4923 and that area or piece of ground extending to 713 square metres or thereby inv 2389.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 apr 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    Standard security
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 06 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    397 square metres at post avenue, inverness inv 7024 and the air space extending upwards partly form a level of 11870MM or thereby above ordnance datum and partly from a level of 11180MM or thereby above ordnance datum at post officeavenue, inverness inv 8420.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 25 mar 2005
    Consegnato il 05 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    397 square metres at post avenue, inverness & air space above post office avenue, inverness INV7024 INV8420.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 25 mar 2005
    Consegnato il 30 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond dated 15 february 2005
    Brevi particolari
    That area of ground lying on the north west side of strothers lane, inverness extending to 1325.1 square metres (title number INV4923) and that piece of ground at strothers lane, inverness extending to 713 square metres (title number INV2389) under exception of that plot of ground at margaret street, inverness extending to 40.6 square metres (title number INV10039) and that triangular plot of ground at strothers lane, inverness.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 22 feb 2005
    Consegnato il 24 feb 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 mag 2005Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • Ha modifiche all'ordine:

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0