DONSIDE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDONSIDE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC279243
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DONSIDE LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova DONSIDE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sanctuary House 7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DONSIDE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HBJ 719 LIMITED01 feb 200501 feb 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di DONSIDE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per DONSIDE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2022 al 30 set 2022

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2021

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Anthony Neil King come amministratore in data 25 set 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Edward Henry Lunt come amministratore in data 22 mag 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Peter John Williams come amministratore in data 01 gen 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Craig Jon Moule come amministratore in data 01 gen 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    15 pagineAA

    Seconda presentazione per la cessazione di Craig Moule come segretario

    5 pagineRP04TM02

    Seconda presentazione per la nomina di Mrs Nicole Seymour come segretario

    6 pagineRP04AP03

    Cessazione della carica di Craig Jon Moule come segretario in data 25 mag 2018

    1 pagineTM02
    Note
    DataNota
    12 lug 2018Second Filing The information on the form TM02 has been replaced by a second filing on 12/07/2018

    Nomina di Mrs Nicole Seymour come segretario in data 25 mag 2018

    2 pagineAP03
    Note
    DataNota
    12 lug 2018Second Filing The information on the form AP03 has been replaced by a second filing on 12/07/2018

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Sophie Atkinson come segretario in data 17 nov 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Craig Jon Moule come segretario in data 17 nov 2017

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di DONSIDE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SEYMOUR, Nicole
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Segretario
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    246824440001
    LUNT, Edward Henry
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Amministratore
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    EnglandBritishDirector258777900001
    WILLIAMS, Peter John
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Amministratore
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    EnglandBritishDirector163514920001
    ATKINSON, Sophie
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Segretario
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    190170780001
    MOULE, Craig Jon
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Segretario
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    240635200001
    MOULE, Craig Jon
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    Segretario
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    173187820001
    HBJ SECRETARIAL LIMITED
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Midlothian
    900026260001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House
    United Kingdom
    Segretario
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01447749
    111982890001
    BURT, Richard George Vincent
    The Old Rectory
    Burton Agnes
    YO25 4NB Driffield
    North Humberside
    Amministratore
    The Old Rectory
    Burton Agnes
    YO25 4NB Driffield
    North Humberside
    United KingdomBritishDirector65537860003
    GRANT, Alan Bryce
    Shop House
    Old Rayne
    AB52 6RY Insch
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Shop House
    Old Rayne
    AB52 6RY Insch
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishChief Executive62175950001
    HENDRY, Sylvia Margaret
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    Amministratore
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    ScotlandBritishCompany Director153666970002
    KING, Anthony Neil
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Amministratore
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    EnglandBritishGroup Director - Capital Investment9255540009
    MARTIN, Peter Joseph
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    Amministratore
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector97475050001
    MCKINNON, John Strathdee
    21 Cava Close
    AB15 6WL Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    21 Cava Close
    AB15 6WL Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishGeneral Manager114336710001
    MOULE, Craig Jon
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Amministratore
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    EnglandBritishDirector135984850005
    MOULE, Craig Jon
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    Amministratore
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Director - Finance And Resources135984850003
    MURRAY, Alexander Birnie
    Burnhaven
    Strachan
    AB31 6NL Banchory
    Kincardineshire
    Amministratore
    Burnhaven
    Strachan
    AB31 6NL Banchory
    Kincardineshire
    United KingdomBritishChief Executive27214860003
    RUFF, Jeremy
    67 Ashmead Road
    Deptford
    SE8 4BY London
    Amministratore
    67 Ashmead Road
    Deptford
    SE8 4BY London
    United KingdomBritishCompany Director103688770001
    VAN DER LEE, Martinus Jacobus Maria
    23 Pitfour Court
    AB42 2YG Peterhead
    Aberdeenshire
    Amministratore
    23 Pitfour Court
    AB42 2YG Peterhead
    Aberdeenshire
    ScotlandDutchCarer70371220001
    HENDERSON BOYD JACKSON LIMITED
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore delegato nominato
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Midlothian
    900026250001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DONSIDE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Sanctuary Housing Association
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    England
    28 apr 2016
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    England
    No
    Forma giuridicaRegistered Society
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCo-Operative And Community Benefit Societies Act 2014
    Luogo di registrazioneFca Mutuals Public Register
    Numero di registrazione19059r
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    DONSIDE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 22 mag 2012
    Consegnato il 07 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Obligations in terms of the agreement
    Brevi particolari
    Several areas of ground at donside village, aberdeen, title number ABN14908.
    Persone aventi diritto
    • Chap Homes Limited
    Transazioni
    • 07 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 13 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 02 mag 2012
    Consegnato il 10 mag 2012
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground at gordon mills road, aberdeen, known as the former donside paper mill aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Aberdeen City Council
    Transazioni
    • 10 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    Standard security
    Creato il 10 giu 2005
    Consegnato il 18 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The property known as donside paper mill, gordon mills road, aberdeen abn 14908.
    Persone aventi diritto
    • Adam & Company PLC
    Transazioni
    • 18 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Bond & floating charge
    Creato il 31 mag 2005
    Consegnato il 04 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Adam & Company PLC
    Transazioni
    • 04 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0