GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED

GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC292695
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Addleshaw Goddard Llp Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WEST COAST CAPITAL (HORTIS) LIMITED27 feb 200627 feb 2006
    PACIFIC SHELF 1351 LIMITED03 nov 200503 nov 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato)

    7 pagineLIQ13(Scot)

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 mag 2020

    LRESSP

    Cessazione della carica di Laura Harradine-Greene come segretario in data 07 mag 2020

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 30 dic 2018

    27 pagineAA

    Cessazione della carica di Justin Matthew King come amministratore in data 04 mar 2020

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 13 Queen's Road Aberdeen AB15 4YL a C/O Addleshaw Goddard Llp Exchange Tower 19 Canning Street Edinburgh EH3 8EH in data 17 dic 2019

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Anthony Gerald Jones come amministratore in data 06 dic 2019

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 06 nov 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of the share premium account 30/10/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere SC2926950009 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC2926950012 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC2926950010 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere SC2926950011 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    29 pagineAA

    Nomina di Mr Richard Maclachlan come amministratore in data 01 feb 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Roger Mclaughlan come amministratore in data 01 feb 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Justin Matthew King come amministratore in data 01 nov 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Laura Harradine-Greene come segretario in data 01 feb 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Mary Elizabeth Bourlet come segretario in data 01 feb 2018

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 nov 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MACLACHLAN, Richard John
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    C/O Addleshaw Goddard Llp
    Scotland
    Amministratore
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    C/O Addleshaw Goddard Llp
    Scotland
    EnglandBritish255019700001
    BOURLET, Mary Elizabeth
    Syon Park, London Road
    Brentford
    TW8 8JF Middlesex
    Wyevale Garden Centres
    England
    Segretario
    Syon Park, London Road
    Brentford
    TW8 8JF Middlesex
    Wyevale Garden Centres
    England
    213121340002
    HAMILTON, Kirsty Elizabeth
    23 Speyburn Place
    Lawthorn
    KA11 2BE Irvine
    Ayrshire
    Segretario
    23 Speyburn Place
    Lawthorn
    KA11 2BE Irvine
    Ayrshire
    British127615890001
    HARRADINE-GREENE, Laura
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    C/O Addleshaw Goddard Llp
    Scotland
    Segretario
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    C/O Addleshaw Goddard Llp
    Scotland
    242726430001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    Segretario
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    British72128340003
    SEALES, Sharon
    22 Earlswood Wynd
    Montgomerie Park
    KA11 2FF Irvine
    Ayrshire
    Segretario
    22 Earlswood Wynd
    Montgomerie Park
    KA11 2FF Irvine
    Ayrshire
    British106673560001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United Kingdom
    Segretario
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United Kingdom
    173148570001
    WARD, Elizabeth Ann
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Segretario
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    205482880001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Segretario nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Amministratore
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    EnglandBritish124019940001
    DAVIDSON, Paul Richmond
    Alloway Cottage
    4 Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayrshire
    Amministratore
    Alloway Cottage
    4 Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayrshire
    United KingdomBritish114537830001
    GATELEY, Donald Kenneth
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    Amministratore
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    United KingdomBritish104442220001
    HUSTAD, Hans Kristian
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Amministratore
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Norwegian103594230001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish72128340003
    JONES, Anthony Gerald
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Amministratore
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    EnglandBritish212265950002
    KING, Justin Matthew
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    C/O Addleshaw Goddard Llp
    Scotland
    Amministratore
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    C/O Addleshaw Goddard Llp
    Scotland
    EnglandBritish254876200001
    KING, Justin Matthew
    Syon Park, London Road
    Brentford
    TW8 8JF Middlesex
    Wyevale Garden Centres
    England
    Amministratore
    Syon Park, London Road
    Brentford
    TW8 8JF Middlesex
    Wyevale Garden Centres
    England
    United KingdomBritish213157990001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124967710001
    LESLAU, Nicholas Mark
    48a Upper Brook Street
    W1K 2BT London
    Amministratore
    48a Upper Brook Street
    W1K 2BT London
    United KingdomBritish6815470015
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    Amministratore
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    WalesBritish1470180001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Amministratore
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    EnglandBritish208653010001
    MCMAHON, James Cairns
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    Amministratore
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    ScotlandBritish159708270001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United Kingdom
    Amministratore
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United Kingdom
    EnglandBritish162853840001
    PIERPOINT, David Julian
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    Amministratore
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    EnglandBritish138653690001
    PITCHER, Stephen John
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United Kingdom
    Amministratore
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United Kingdom
    United KingdomBritish138172490001
    ROBERTSON, Lorraine Anne
    St. Leonards Forest
    RH13 6PH Horsham
    Boundary Cottage
    West Sussex
    Amministratore
    St. Leonards Forest
    RH13 6PH Horsham
    Boundary Cottage
    West Sussex
    EnglandBritish138172640001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Amministratore
    Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    United KingdomGerman126422100002
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Amministratore delegato nominato
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Garden Centre Group Limited
    Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Scotland
    06 apr 2016
    Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Scotland
    Numero di registrazioneSc324083
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 set 2017
    Consegnato il 02 ott 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All current and future material property and material intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the debenture registered by this form MR01 (the "debenture"). For more details please refer to the debenture.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 02 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 set 2017
    Consegnato il 29 set 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 29 set 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 set 2017
    Consegnato il 27 set 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 27 set 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 set 2017
    Consegnato il 26 set 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 26 set 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed
    Creato il 24 apr 2012
    Consegnato il 03 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 17 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 24 apr 2012
    Consegnato il 03 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 17 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 24 feb 2009
    Consegnato il 04 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 mar 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 24 feb 2009
    Consegnato il 04 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 mar 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Supplemental charge
    Creato il 12 feb 2007
    Consegnato il 01 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The supplemental chargor with full title guarantee and as a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities, has assigned, in favour of the security agent all its rights title and interest in and to the loan agreement and the borrower security documents.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Floating charge
    Creato il 20 apr 2006
    Consegnato il 04 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed charges over land and other assets (see paper apart 2 for details)including assignment and floating charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 mar 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 20 apr 2006
    Consegnato il 04 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 mar 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 27 feb 2006
    Consegnato il 08 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)

    GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    2
    DataTipo
    09 feb 2021Data prevista di scioglimento
    28 mag 2020Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0