FDC TECHNOLOGY LIMITED

FDC TECHNOLOGY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFDC TECHNOLOGY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC296391
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FDC TECHNOLOGY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FDC TECHNOLOGY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    (Gf) 6 Fairways Business Park
    Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    West Lothian
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FDC TECHNOLOGY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INVOCAS PERSONAL DEBT SOLUTIONS LIMITED31 gen 200631 gen 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di FDC TECHNOLOGY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per FDC TECHNOLOGY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    5 pagineAA

    Nomina di Morton Fraser Secretaries Limited come segretario in data 09 dic 2016

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Julie-Anne Afrin come segretario in data 09 dic 2016

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 feb 2016

    Stato del capitale al 04 feb 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da James Miller House 98 West George Street Glasgow G2 1PJ a (Gf) 6 Fairways Business Park Deer Park Avenue Livingston West Lothian EH54 8AF in data 15 set 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 feb 2015

    Stato del capitale al 02 feb 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mar 2014

    Stato del capitale al 18 mar 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Parsliffe come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Julie-Anne Afrin come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Parsliffe come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Brian Ferguson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Caroline Reynolds come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Caroline Feely come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Caroline Michelle Reynolds come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Caroline Mary Yuille Feely come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di FDC TECHNOLOGY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor, Quartermile Two
    Scotland
    Segretario
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor, Quartermile Two
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC262093
    95512800001
    HALL, John Michael
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    United Kingdom
    Amministratore
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    United Kingdom
    ScotlandBritish107926760002
    AFRIN, Julie-Anne
    Fairways Business Park
    Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    (Gf) 6
    West Lothian
    Scotland
    Segretario
    Fairways Business Park
    Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    (Gf) 6
    West Lothian
    Scotland
    178001110001
    DRUMMOND, Robert Lindsay
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    Segretario
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    British136151950001
    HALL, John Michael
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    Segretario
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    British167364470001
    LIGHTLEY, Stephen John
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Segretario
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British47296680002
    PARSLIFFE, Andrew John
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    Segretario
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    British169955670001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Segretario nominato
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    BELL, Howard James
    The Manor House
    Nesfield
    LS29 0BN Ilkley
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Manor House
    Nesfield
    LS29 0BN Ilkley
    North Yorkshire
    British8909130003
    DRUMMOND, Robert Lindsay
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    Amministratore
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    ScotlandBritish136151950001
    FEELY, Caroline Mary Yuille
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    Amministratore
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish172352200001
    FERGUSON, Brian
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    Amministratore
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    ScotlandBritish154774310001
    HALL, John Michael
    31 Lauder Road
    EH9 2JG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    31 Lauder Road
    EH9 2JG Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish107926760002
    LEWIS, Peter Cyril Robert
    Abbey House Moorland Road
    Bramhope
    LS16 9HW Leeds
    Amministratore
    Abbey House Moorland Road
    Bramhope
    LS16 9HW Leeds
    EnglandBritish56467830001
    LIGHTLEY, Stephen John
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Amministratore
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish47296680002
    MACMILLAN, David Roy
    Gosford Road
    Longniddry
    EH32 0LF East Lothian
    Martinknowe
    Amministratore
    Gosford Road
    Longniddry
    EH32 0LF East Lothian
    Martinknowe
    ScotlandBritish175002230001
    PARSLIFFE, Andrew John
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    Amministratore
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish67033440002
    REYNOLDS, Caroline Michelle
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    Amministratore
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish176061270001
    WRIGHT, Ian William
    Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    5
    Amministratore
    Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    5
    ScotlandBritish111353760002
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Amministratore delegato nominato
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FDC TECHNOLOGY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Invocas Group Plc
    Fairways Business Park, Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    Gf, 6 Deer Park Avenue
    Scotland
    07 dic 2016
    Fairways Business Park, Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    Gf, 6 Deer Park Avenue
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneScotla
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc295886
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    FDC TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 02 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 nov 2010Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 03 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0