TMRI LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTMRI LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC298414
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TMRI LIMITED?

    • Altre ricerche e sviluppo sperimentale in scienze naturali e ingegneria (72190) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TMRI LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    168 Bath Street
    G2 4TP Glasgow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TMRI LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per TMRI LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 apr 2016

    Stato del capitale al 04 apr 2016

    • Capitale: GBP 9,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Professor Steven Peter Beaumont il 01 mar 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Graham Hamilton Mckee il 24 mar 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati

    2 pagineCH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2016 al 30 giu 2016

    3 pagineAA01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mar 2015

    Stato del capitale al 24 mar 2015

    • Capitale: GBP 9,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    11 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 apr 2014

    Stato del capitale al 24 apr 2014

    • Capitale: GBP 9,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Colin Masson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di David Griffin come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * No 13 the Square University Avenue Glasgow G12 8QQ* in data 06 mag 2011

    1 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG03s

    Chi sono gli amministratori di TMRI LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PATERSON, Graham
    2 Acer Crescent
    Auld Balgonie
    PA2 9LR Paisley
    Renfrewshire
    Segretario
    2 Acer Crescent
    Auld Balgonie
    PA2 9LR Paisley
    Renfrewshire
    British27226290002
    BEAUMONT, Steven Peter, Professor
    James Watt South
    University Avenue, University Of Glasgow
    G12 8QQ Glasgow
    C/O Quantic Innovation Space
    Scotland
    Amministratore
    James Watt South
    University Avenue, University Of Glasgow
    G12 8QQ Glasgow
    C/O Quantic Innovation Space
    Scotland
    United KingdomBritish49330440001
    BROWN, Julia Mary
    Waterloo Street
    G2 6HQ Glasgow
    50
    Scotland
    Amministratore
    Waterloo Street
    G2 6HQ Glasgow
    50
    Scotland
    ScotlandScottish65822270002
    MCKEE, Graham Hamilton
    c/o University Of Dundee
    Perth Road
    Nethergate
    DD1 4HN Dundee
    11
    Scotland
    Amministratore
    c/o University Of Dundee
    Perth Road
    Nethergate
    DD1 4HN Dundee
    11
    Scotland
    ScotlandBritish44787000001
    NEWBY, David Ernest, Professor
    Little France Crescent
    EH16 4SB Edinburgh
    Chancellor's Building, 49
    Lothian
    Scotland
    Amministratore
    Little France Crescent
    EH16 4SB Edinburgh
    Chancellor's Building, 49
    Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish150269030001
    RATTRAY, Elizabeth-Ann Simpson, Doctor
    c/o University Of Aberdeen
    Regent Walk
    AB24 3FX Aberdeen
    Kings College
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    c/o University Of Aberdeen
    Regent Walk
    AB24 3FX Aberdeen
    Kings College
    Aberdeenshire
    Scotland
    United KingdomBritish76991750003
    SHARP, Alan
    c/o Nhs Grampian
    Westholme
    AB15 6LS Aberdeen
    Woodend Hospital
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    c/o Nhs Grampian
    Westholme
    AB15 6LS Aberdeen
    Woodend Hospital
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish113387390001
    BROWN, Janet Marjorie, Dr
    33 South Avenue
    PA2 7SG Paisley
    Renfrewshire
    Segretario
    33 South Avenue
    PA2 7SG Paisley
    Renfrewshire
    British78477590001
    CHARLOTTE SECRETARIES LIMITED
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2ET Edinburgh
    Lothian
    Segretario nominato
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2ET Edinburgh
    Lothian
    900029730001
    ALLISON, Rhona Stoddart
    c/o Scottish Enterprise
    50 Waterloo Street
    G2 6HQ Glasgow
    Atrium Court
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Scottish Enterprise
    50 Waterloo Street
    G2 6HQ Glasgow
    Atrium Court
    United Kingdom
    ScotlandBritish85537460001
    BROWN, Janet Marjorie, Dr
    33 South Avenue
    PA2 7SG Paisley
    Renfrewshire
    Amministratore
    33 South Avenue
    PA2 7SG Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandBritish78477590001
    COWAN, Brian
    5 Jackson Place
    Canniesburn
    G61 1RY Glasgow
    4/2
    United Kingdom
    Amministratore
    5 Jackson Place
    Canniesburn
    G61 1RY Glasgow
    4/2
    United Kingdom
    ScotlandBritish112687080002
    GRIFFIN, David Douglas
    c/o Nhs Greater Glasgow & Clyde Corporate Hq
    Gartnavel Royal Hospital
    1055 Great Western Road
    G12 0XH Glasgow
    Jb Russell House
    Lanarkshire
    Scotland
    Amministratore
    c/o Nhs Greater Glasgow & Clyde Corporate Hq
    Gartnavel Royal Hospital
    1055 Great Western Road
    G12 0XH Glasgow
    Jb Russell House
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish126401830001
    HALL, John Martin
    Carolside Cottage
    TD4 6AL Earlston
    Berwickshire
    Amministratore
    Carolside Cottage
    TD4 6AL Earlston
    Berwickshire
    ScotlandBritish85371420002
    HOUSTON, James
    2 Melginch Steadings
    Balbeggie
    PH1 6HJ Perth
    Amministratore
    2 Melginch Steadings
    Balbeggie
    PH1 6HJ Perth
    ScotlandBritish103084780001
    MACDONALD, Laura Elizabeth Anne
    22/2 Summerside Place
    EH6 4NZ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    22/2 Summerside Place
    EH6 4NZ Edinburgh
    Midlothian
    British112687480001
    MACLEOD, Alison Murray, Professor
    43 Forest Road
    AB15 4BY Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    43 Forest Road
    AB15 4BY Aberdeen
    Aberdeenshire
    British113387280001
    MASSON, Colin James
    c/o C/O Tayside Nhs Board
    Ninewells Campus
    DD1 9SY Dundee
    Ninewells Hospital & Medical School
    Scotland
    Amministratore
    c/o C/O Tayside Nhs Board
    Ninewells Campus
    DD1 9SY Dundee
    Ninewells Hospital & Medical School
    Scotland
    ScotlandBritish157857960001
    MASSON, Colin James
    5 Glamis Gardens
    KY11 9TD Dalgety Bay
    Fife
    Amministratore
    5 Glamis Gardens
    KY11 9TD Dalgety Bay
    Fife
    ScotlandBritish157857960001
    MATHESON, John Alexander
    38 Netherby Road
    EH5 3LX Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    38 Netherby Road
    EH5 3LX Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish66781480001
    MCGEOUGH, Brian Christopher
    30 Brodie Park Crescent
    PA2 6EU Paisley
    Renfrewshire
    Amministratore
    30 Brodie Park Crescent
    PA2 6EU Paisley
    Renfrewshire
    British112687030001
    PATERSON, Graham
    c/o University Of Glasgow
    The Square
    University Avenue
    G12 8QQ Glasgow
    13
    Lanarkshire
    Scotland
    Amministratore
    c/o University Of Glasgow
    The Square
    University Avenue
    G12 8QQ Glasgow
    13
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish27226290002
    PAUL, Nigel Anthony Lewis
    c/o University Of Edinburgh
    9-16 Chambers Street
    EH1 1HT Edinburgh
    Charles Stewart House
    Lothian
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o University Of Edinburgh
    9-16 Chambers Street
    EH1 1HT Edinburgh
    Charles Stewart House
    Lothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish93115070002
    PERRY, John Scott
    150 Broomielaw
    Atlantic Quay
    G2 8LU Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    150 Broomielaw
    Atlantic Quay
    G2 8LU Glasgow
    Lanarkshire
    British/Usa120686870001
    SWAINSON, Charles Patrick, Dr
    33 Granby Road
    EH16 5NP Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    33 Granby Road
    EH16 5NP Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish63437980001
    WELLS, William James, Professor
    c/o Nhs Tayside
    Kings Cross Hospital
    Clepington Road
    DD3 8EA Dundee
    Nhs Tayside Board Office
    Scotland
    Amministratore
    c/o Nhs Tayside
    Kings Cross Hospital
    Clepington Road
    DD3 8EA Dundee
    Nhs Tayside Board Office
    Scotland
    ScotlandBritish159356160001

    TMRI LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 03 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Enterprise
    Transazioni
    • 03 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Bond & floating charge
    Creato il 03 apr 2006
    Consegnato il 05 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Scottish Enterprise
    Transazioni
    • 05 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0