APHILITY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAPHILITY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC308451
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di APHILITY LIMITED?

    • Trattamento dei dati, hosting e attività correlate (63110) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova APHILITY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    (Gf) 6 Fairways Business Park
    Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    West Lothian
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di APHILITY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE AFFORDABILITY ASSESSMENT CENTRE LIMITED24 giu 201524 giu 2015
    DEBT SOLUTIONS SCOTLAND LIMITED24 apr 200724 apr 2007
    TM 1266 LIMITED12 set 200612 set 2006

    Quali sono gli ultimi bilanci di APHILITY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per APHILITY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di David Ewing come amministratore in data 31 gen 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Morton Fraser Secretaries Limited come segretario in data 09 dic 2016

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Julie-Anne Afrin come amministratore in data 09 dic 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Julie-Anne Afrin come segretario in data 09 dic 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    18 pagineAA

    Nomina di Mr David Ewing come amministratore in data 29 set 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Amerigo Dinolfi come amministratore in data 30 set 2016

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name08 set 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 01 set 2016

    RES15

    Iscrizione dell'ipoteca SC3084510001, creata il 26 mag 2016

    17 pagineMR01

    Nomina di Mrs Julie-Anne Afrin come amministratore in data 01 mag 2016

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da (Gf) 6 Bellsquarry Livingston West Lothian EH54 9AF a (Gf) 6 Fairways Business Park Deer Park Avenue Livingston West Lothian EH54 8AF in data 15 set 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 set 2015

    Stato del capitale al 14 set 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da (Gf) 6 Fairways Business Park Deer Park Avenue Livingston West Lothian EH54 8AF Scotland a (Gf) 6 Bellsquarry Livingston West Lothian EH54 9AF in data 14 set 2015

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da James Miller House 98 West George Street Glasgow G2 1PJ a (Gf) 6 Bellsquarry Livingston West Lothian EH54 9AF in data 14 set 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Amerigo Dinolfi come amministratore in data 01 lug 2015

    2 pagineAP01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed debt solutions scotland LIMITED\certificate issued on 24/06/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name24 giu 2015

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 23 giu 2015

    RES15

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 set 2014

    Stato del capitale al 17 set 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    2 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 set 2013

    Stato del capitale al 13 set 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Andrew Parsliffe come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di APHILITY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor, Quartermile Two
    Scotland
    Segretario
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor, Quartermile Two
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC262093
    95512800001
    HALL, John Michael
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    Amministratore
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    ScotlandBritish107926760002
    AFRIN, Julie-Anne
    Fairways Business Park
    Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    (Gf) 6
    West Lothian
    Scotland
    Segretario
    Fairways Business Park
    Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    (Gf) 6
    West Lothian
    Scotland
    178001400001
    DRUMMOND, Robert Lindsay
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    Segretario
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    British136151950001
    HALL, John Michael
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    Segretario
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    British167363430001
    LIGHTLEY, Stephen John
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Segretario
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British47296680002
    PARSLIFFE, Andrew John
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    Segretario
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    British169955790001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003420001
    AFRIN, Julie-Anne
    Fairways Business Park
    Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    Gf, 6 Deer Park Ave
    West Lothian
    Scotland
    Amministratore
    Fairways Business Park
    Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    Gf, 6 Deer Park Ave
    West Lothian
    Scotland
    United KingdomBritish208706470001
    DINOLFI, Amerigo
    Fairways Business Park
    Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    (Gf) 6
    West Lothian
    Scotland
    Amministratore
    Fairways Business Park
    Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    (Gf) 6
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish199405170001
    DRUMMOND, Robert Lindsay
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    Amministratore
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    ScotlandBritish136151950001
    EWING, David
    Fairways Business Park
    Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    (Gf) 6
    West Lothian
    Scotland
    Amministratore
    Fairways Business Park
    Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    (Gf) 6
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish86695980003
    FERGUSON, Brian
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    Amministratore
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    ScotlandBritish154774310001
    HALL, John Michael
    31 Lauder Road
    EH9 2JG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    31 Lauder Road
    EH9 2JG Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish107926760002
    LIGHTLEY, Stephen John
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Amministratore
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish47296680002
    MACMILLAN, David Roy
    Gosford Road
    Longniddry
    EH32 0LF East Lothian
    Martinknowe
    Amministratore
    Gosford Road
    Longniddry
    EH32 0LF East Lothian
    Martinknowe
    ScotlandBritish175002230001
    PARSLIFFE, Andrew John
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    Amministratore
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish67033440002
    WRIGHT, Ian William
    Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    5
    Amministratore
    Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    5
    ScotlandBritish111353760002
    REYNARD NOMINEES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore delegato nominato
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900011050001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore delegato nominato
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003410001

    Chi sono le persone con controllo significativo di APHILITY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Invocas Group Plc
    Fairways Business Park, Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    Gf 6 Deer Park Avenue
    Scotland
    06 apr 2016
    Fairways Business Park, Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    Gf 6 Deer Park Avenue
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc295886
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    APHILITY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 mag 2016
    Consegnato il 07 giu 2016
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Kpi (Nominees) Limited
    Transazioni
    • 07 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0