THE BUCCLEUCH LIVING HERITAGE TRUST
Panoramica
Nome della società | THE BUCCLEUCH LIVING HERITAGE TRUST |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited' |
Numero di società | SC377083 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE BUCCLEUCH LIVING HERITAGE TRUST?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova THE BUCCLEUCH LIVING HERITAGE TRUST?
Indirizzo della sede legale | C/O Anderson Strathern Llp 58 Morrison Street EH3 8BP Edinburgh Scotland |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE BUCCLEUCH LIVING HERITAGE TRUST?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 ott 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 lug 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 ott 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THE BUCCLEUCH LIVING HERITAGE TRUST?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 19 apr 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 03 mag 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 19 apr 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per THE BUCCLEUCH LIVING HERITAGE TRUST?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Iscrizione dell'ipoteca SC3770830012, creata il 28 mar 2025 | 18 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca SC3770830013, creata il 28 mar 2025 | 19 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca SC3770830014, creata il 28 mar 2025 | 18 pagine | MR01 | ||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Cessazione della carica di Rosalind Joy Savill Dbe Cbe come amministratore in data 27 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Bernard Franklin Higgins il 11 dic 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Duke of Buccleuch and Queensberry Richard Walter John Montagu Douglas Scott Kt Kbe il 11 dic 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Rodger Gow il 11 dic 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Colin Bruce Henderson il 11 dic 2023 | 1 pagine | CH03 | ||
Bilancio redatto al 31 ott 2023 | 36 pagine | AA | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Rutland Court Edinburgh Midlothian EH3 8EY a C/O Anderson Strathern Llp 58 Morrison Street Edinburgh EH3 8BP in data 12 gen 2024 | 1 pagine | AD01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca SC3770830011, creata il 06 lug 2023 | 15 pagine | MR01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Earl of Dalkeith Walter John Francis Montagu Douglas Scott il 19 apr 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio redatto al 31 ott 2022 | 40 pagine | AA | ||
Iscrizione dell'ipoteca SC3770830010, creata il 04 gen 2023 | 17 pagine | MR01 | ||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 ott 2021 | 40 pagine | AA | ||
Nomina di Earl of Dalkeith Walter John Francis Montagu Douglas Scott come amministratore in data 08 mar 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio redatto al 31 ott 2020 | 39 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Duke of Buccleuch and Queensberry Richard Walter John Montagu Douglas Scott il 18 apr 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Chi sono gli amministratori di THE BUCCLEUCH LIVING HERITAGE TRUST?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENDERSON, Colin Bruce | Segretario | 58 Morrison Street EH3 8BP Edinburgh C/O Anderson Strathern Llp Scotland | 150627670001 | |||||||
BORMAN, Tracy Joanne, Dr | Amministratore | 58 Morrison Street EH3 8BP Edinburgh C/O Anderson Strathern Llp Scotland | England | British | Director | 208034090001 | ||||
DOUGLAS SCOTT KT KBE, Richard Walter John Montagu, Duke Of Buccleuch And Queensberry | Amministratore | 58 Morrison Street EH3 8BP Edinburgh C/O Anderson Strathern Llp Scotland | Scotland | British | Company Director | 94874600006 | ||||
GOW, Ian Rodger | Amministratore | 58 Morrison Street EH3 8BP Edinburgh C/O Anderson Strathern Llp Scotland | United Kingdom | British | Retired | 201751990001 | ||||
HIGGINS, Bernard Franklin | Amministratore | 58 Morrison Street EH3 8BP Edinburgh C/O Anderson Strathern Llp Scotland | United Kingdom | British | Company Director | 263563390003 | ||||
MONTAGU DOUGLAS SCOTT, Walter John Francis, Earl Of Dalkeith | Amministratore | 58 Morrison Street EH3 8BP Edinburgh C/O Anderson Strathern Llp Scotland | United Kingdom | British | Company Director | 293646480002 | ||||
ROBINSON, John James Michael Laud, Sir | Amministratore | 58 Morrison Street EH3 8BP Edinburgh C/O Anderson Strathern Llp Scotland | England | British | Director | 15955200001 | ||||
WEEKS OBE, Wilfred John Thomas | Amministratore | 58 Morrison Street EH3 8BP Edinburgh C/O Anderson Strathern Llp Scotland | England | British | Director | 30728560002 | ||||
BELLAMY, OBE, David James, Dr | Amministratore | Rutland Court EH3 8EY Edinburgh 1 Midlothian | England | British | Director | 2748250002 | ||||
BLAIR, John Woodman | Amministratore | Rutland Court EH3 8EY Edinburgh 1 Midlothian | Scotland | British | None | 57163970001 | ||||
BUCCLEUCH, Elizabeth Marian Frances, Duchess | Amministratore | Rutland Court EH3 8EY Edinburgh 1 Midlothian | Scotland | British | Director | 150627690001 | ||||
COOKE, Stephen Giles | Amministratore | Rutland Court EH3 8EY Edinburgh 1 Midlothian | England | British | Solicitor | 17286980002 | ||||
GLEN, John Ronald Kerr | Amministratore | Rutland Court EH3 8EY Edinburgh 1 Midlothian | Scotland | British | None | 134679420002 | ||||
SAVILL DBE CBE, Rosalind Joy, Dame | Amministratore | 58 Morrison Street EH3 8BP Edinburgh C/O Anderson Strathern Llp Scotland | United Kingdom | British | Director | 56364780002 | ||||
STEEL, Judith Mary, Lady | Amministratore | Rutland Court EH3 8EY Edinburgh 1 Midlothian | Scotland | British | None | 151116170001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE BUCCLEUCH LIVING HERITAGE TRUST?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Duke Of Buccleuch And Queensberry Richard Walter John Montagu Douglas Scott Kt Kbe | 19 apr 2017 | 58 Morrison Street EH3 8BP Edinburgh C/O Anderson Strathern Llp Scotland | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: Scotland | |||
Natura del controllo
|
THE BUCCLEUCH LIVING HERITAGE TRUST ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 28 mar 2025 Consegnato il 01 apr 2025 | In corso | ||
Breve descrizione The white lion, holyhead road, ketley, telford, TF1 5JD and registered at the land registry under title number SL26307; and land adjoining the white lion, holyhead road, ketley, telford, TF1 5DJ and registered at land registry under title number SL155409. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 28 mar 2025 Consegnato il 01 apr 2025 | In corso | ||
Breve descrizione Land on the north side of eden drive, colchester as shown edged red on the plan (as such plan is annexed in the instrument evidencing the charge accompanying this form MR01) and registered at land registry under title number AA80117. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 28 mar 2025 Consegnato il 01 apr 2025 | In corso | ||
Breve descrizione 93-99 ladywell road, london, SE13 7JA and registered at land registry under title number TGL626581. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 06 lug 2023 Consegnato il 11 lug 2023 | In corso | ||
Breve descrizione The property known as 567 chorley new road, horwich, greater manchester and registered at the land registry under title number MAN272928. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 04 gen 2023 Consegnato il 05 gen 2023 | In corso | ||
Breve descrizione By way of legal charge, the leasehold land at site 54 grearshill road, kingstown industrial estate, carlisle, CA3 0ET shown edged red on the plan attached to the charge instrument and held by the chargor pursuant to a lease made between the chargor and the council of the city of carlisle. Please see the charge instrument for further details. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 12 lug 2017 Consegnato il 20 lug 2017 | In corso | ||
Breve descrizione All and whole the subjects on the north side of brand street, glasgow, GLA206447. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 31 dic 2015 Consegnato il 08 gen 2016 | In corso | ||
Breve descrizione Subjects lying to the north west of main street, bellshill. LAN38913. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 dic 2012 Consegnato il 29 dic 2012 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Leasehold property forming unit 1, phase 12 gillingham business park, gillingham kent, title number K573341. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 27 dic 2012 Consegnato il 09 gen 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 33 to 41 west bowling green street, edinburgh, title number MID51691. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 27 dic 2012 Consegnato il 09 gen 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 4 norton park, edinburgh, title number MID51687. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 27 dic 2012 Consegnato il 09 gen 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 41 and 43 quarry street, hamilton, title number LAN145398. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 21 dic 2012 Consegnato il 29 dic 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Leasehold property forming part of kingstown industrial estate, carlisle, title number CU52670. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 21 dic 2012 Consegnato il 29 dic 2012 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Leasehold property being the links business centre, old woking road, old woking, title number SY704390. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 31 mag 2011 Consegnato il 03 giu 2011 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 1-26 broompark, edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0