HUB WEST SCOTLAND PROJECT COMPANY (NO.5) LIMITED

HUB WEST SCOTLAND PROJECT COMPANY (NO.5) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHUB WEST SCOTLAND PROJECT COMPANY (NO.5) LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC524087
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di HUB WEST SCOTLAND PROJECT COMPANY (NO.5) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova HUB WEST SCOTLAND PROJECT COMPANY (NO.5) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Foresight Group Clarence House
    131-135 George Street
    EH2 4JS Edinburgh
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HUB WEST SCOTLAND PROJECT COMPANY (NO.5) LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HUB WEST SCOTLAND PROJECT COMPANY (NO.5) LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al11 gen 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma25 gen 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al11 gen 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per HUB WEST SCOTLAND PROJECT COMPANY (NO.5) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XDV5A5GB

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2024

    24 pagineAA
    ADEFBBJ7

    Cessazione della carica di Nial Watson Gemmell come amministratore in data 29 feb 2024

    1 pagineTM01
    XCYDMBVN

    Nomina di Mrs Ruth Mairi Hann come amministratore in data 05 mar 2024

    2 pagineAP01
    XCY85OZ4

    Nomina di Mr Alastair William Nicol come amministratore in data 01 mar 2024

    2 pagineAP01
    XCY85I4I

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2024 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    XCVW8X55

    Cessazione della carica di Gordon James Shirreff come amministratore in data 30 nov 2023

    1 pagineTM01
    XCUZY4JL

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2023

    22 pagineAA
    SCC0T7S3

    Indirizzo della sede legale modificato da The Lighthouse 2nd Floor 11 Mitchell Lane Glasgow G1 3NU United Kingdom a C/O Foresight Group Clarence House 131-135 George Street Edinburgh EH2 4JS in data 25 lug 2023

    1 pagineAD01
    XC8J4PNS

    Cessazione della carica di Bina Tailor come amministratore in data 20 giu 2023

    1 pagineTM01
    XC6YVQ8Q

    Nomina di Mr James Thomas Lloyd come amministratore in data 20 giu 2023

    2 pagineAP01
    XC6TNSW0

    Cessazione della carica di Richard John Dixon come amministratore in data 20 giu 2023

    1 pagineTM01
    XC6TNSNU

    Cessazione della carica di Clare Sheridan come segretario in data 20 giu 2023

    1 pagineTM02
    XC6TNSVD

    Cessazione della carica di John William Dryburgh come amministratore in data 20 giu 2023

    1 pagineTM01
    XC6TNSXO

    Iscrizione dell'ipoteca SC5240870007, creata il 20 giu 2023

    24 pagineMR01
    XC6ICTP6

    Cessazione della carica di Marion Grey Easton Speirs come amministratore in data 15 giu 2023

    1 pagineTM01
    XC5RNCKZ

    Iscrizione dell'ipoteca SC5240870006, creata il 14 apr 2023

    24 pagineMR01
    XC1QPPLM

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Proposed remodelling project/authorised by directors to take action/section 175 23/03/2023
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XBV360AZ

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard John Dixon il 26 apr 2022

    2 pagineCH01
    XBGHLQM6

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2022

    22 pagineAA
    SBB3QDFL

    Indirizzo della sede legale modificato da 6th Floor Merchant Exchange 20 Bell Street Glasgow G1 1LG United Kingdom a The Lighthouse 2nd Floor 11 Mitchell Lane Glasgow G1 3NU in data 23 mar 2022

    1 pagineAD01
    XB0E35VT

    Modifica dei dettagli di Hub West Scotland Holdco (No.5) Limited come persona con controllo significativo il 21 mar 2022

    2 paginePSC05
    XB0E35XT

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XAVGSPQG

    Dettagli del direttore cambiati per Bina Tailor il 30 dic 2021

    2 pagineCH01
    XAV3LSRF

    Chi sono gli amministratori di HUB WEST SCOTLAND PROJECT COMPANY (NO.5) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HANN, Ruth Mairi
    91 Haymarket Terrace
    EH12 5HE Edinburgh
    Sft, Fourth Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    91 Haymarket Terrace
    EH12 5HE Edinburgh
    Sft, Fourth Floor
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector289345220001
    LLOYD, James Thomas
    Clarence House
    131-135 George Street
    EH2 4JS Edinburgh
    C/O Foresight Group
    United Kingdom
    Amministratore
    Clarence House
    131-135 George Street
    EH2 4JS Edinburgh
    C/O Foresight Group
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector279200720001
    NICOL, Alastair William
    Fourth Floor, 91 Haymarket Terrace
    EH12 5HE Edinburgh
    The Scottish Futures Trust
    United Kingdom
    Amministratore
    Fourth Floor, 91 Haymarket Terrace
    EH12 5HE Edinburgh
    The Scottish Futures Trust
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector183296710001
    SHERIDAN, Clare
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    Segretario
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    204136120001
    BADHAM, Nigel Paul
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8 Old Jewry
    United Kingdom
    Amministratore
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8 Old Jewry
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector194593210009
    BAILLIE, Andrew James
    Gartnavel Royal Hospital
    1055 Great Western Road
    G12 0XH Glasgow
    Admin Building
    United Kingdom
    Amministratore
    Gartnavel Royal Hospital
    1055 Great Western Road
    G12 0XH Glasgow
    Admin Building
    United Kingdom
    United KingdomScottishSenior Project Manager292562370001
    CAIRNS, Richard
    Council Offices
    Garshake Road
    G82 3PU Dumbarton
    West Dunbartonshire Council
    United Kingdom
    Amministratore
    Council Offices
    Garshake Road
    G82 3PU Dumbarton
    West Dunbartonshire Council
    United Kingdom
    ScotlandBritishStrategic Director Regeneration111937370001
    CAMPBELL, Colin Malcolm
    Skypark 1
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3
    United Kingdom
    Amministratore
    Skypark 1
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector76823200003
    CURRAN, Anthony
    Jb Russell House, Gartnavel Royal Hospital Campus
    1055 Great Western Road
    G12 0XH Glasgow
    C/O Greater Glasgow Health Board
    United Kingdom
    Amministratore
    Jb Russell House, Gartnavel Royal Hospital Campus
    1055 Great Western Road
    G12 0XH Glasgow
    C/O Greater Glasgow Health Board
    United Kingdom
    UkBritishCompany Director204831270002
    DIXON, Richard John
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    Amministratore
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector267912110017
    DREW, Richard Stephen
    Adastral Park
    IP5 3RE Ipswich
    Columba House
    England
    England
    Amministratore
    Adastral Park
    IP5 3RE Ipswich
    Columba House
    England
    England
    United KingdomBritishDirector111864530002
    DRYBURGH, John William
    Rowan House North
    1 The Professional Quarter
    SY2 6LG Shrewsbury
    Cbsl Accountants
    Shropshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Rowan House North
    1 The Professional Quarter
    SY2 6LG Shrewsbury
    Cbsl Accountants
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector109305470002
    ERLAM, Westley Alan
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor279666060001
    FARLEY, George Peter
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8 Old Jewry
    United Kingdom
    Amministratore
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8 Old Jewry
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector123834510001
    GEMMELL, Nial Watson
    11-15 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    Scottish Futures Trust
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    11-15 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    Scottish Futures Trust
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritishInvestments Director176999390001
    GOURLAY, Alastair Graham
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8 Old Jewry
    United Kingdom
    Amministratore
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8 Old Jewry
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector58686920001
    HARROP, Benjamin James
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8 Old Jewry
    United Kingdom
    Amministratore
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8 Old Jewry
    United Kingdom
    United KingdomBritishDevelopment Manager168494030003
    HOPE, John Alexander
    Skypark 1
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3
    United Kingdom
    Amministratore
    Skypark 1
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector71318590003
    LANE, David George
    St John Street
    EC1M 4EH London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    St John Street
    EC1M 4EH London
    100
    United Kingdom
    EnglandBritishCommercial Director160668630001
    MACDONALD, Andrew Edward Douglas
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor154478030001
    MATTHEWS, William Stewart
    Skypark 1
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3
    United Kingdom
    Amministratore
    Skypark 1
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director69372990001
    MCCROSSAN, Margaret Brown Porteous
    Skypark 1
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3
    United Kingdom
    Amministratore
    Skypark 1
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant179597170001
    OTTI, Henry
    St John Street
    EC1M 4EH London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    St John Street
    EC1M 4EH London
    100
    United Kingdom
    EnglandBritishNone259088930001
    POWELL, Andrew John
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director121982700003
    RICHARDSON, Ben Peter
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant206173220001
    SCENNA, Lisa
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomAustralianDirector126881800002
    SCENNA, Lisa
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomAustralianDirector126881800002
    SHIRREFF, Gordon James
    11-15 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    Scottish Futures Trust
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    11-15 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    Scottish Futures Trust
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritishProject Director220299710001
    SPEIRS, Marion Grey Easton
    Gartnavel Royal Hospital
    1055 Great Western Road
    G12 0XH Glasgow
    Admin Building
    United Kingdom
    Amministratore
    Gartnavel Royal Hospital
    1055 Great Western Road
    G12 0XH Glasgow
    Admin Building
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant257225500001
    TAILOR, Bina
    Kent House
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    C/O Morgan Sindall Group Plc
    United Kingdom
    Amministratore
    Kent House
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    C/O Morgan Sindall Group Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant276656960001
    TITMUS, Adam John
    St John Street
    EC1M 4EH London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    St John Street
    EC1M 4EH London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director249256530001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HUB WEST SCOTLAND PROJECT COMPANY (NO.5) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Lower State Of Saxony
    10117 Berlin
    Dorotheenstrasse 74
    Germany
    10 apr 2017
    10117 Berlin
    Dorotheenstrasse 74
    Germany
    No
    Forma giuridicaGovernment Department
    Autorità legaleGermany
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    2nd Floor
    11 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    The Lighthouse
    United Kingdom
    06 apr 2016
    2nd Floor
    11 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    The Lighthouse
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc524083
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0